ZELNOVA SA
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 28/08/2015 | VENDRELL ARISTE GERARD |
Vicesecretario |
| Cese: 28/08/2015 | CUENCA MIRANDA SEBASTIAN |
Secretario |
| Nombramiento: 28/08/2015 | GOMEZ PULIDO JUAN |
Secretario |
| Nombramiento: 28/08/2015 | CUENCA MIRANDA SEBASTIAN |
Vicesecretario |
| Nombramiento: 28/08/2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
| Cese: 28/08/2015 | JEFPO SL |
Consejero |
| Nombramiento: 28/08/2015 | PEREZ ORIVE CARCELLER JOSE FELIX |
Consejero |
| Nombramiento: 11/06/2015 | MIELGO NUÑEZ LUIS ANGEL |
Apoderado |
| Cese: 07/04/2015 | GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO |
Consejero |
| Cese: 21/11/2014 | JEFPO SL |
Consejero |
| Nombramiento: 21/11/2014 | JEFPO SL |
Consejero |
| Nombramiento: 14/08/2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
| Nombramiento: 02/08/2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
| Nombramiento: 14/09/2012 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ZELNOVA SA
28/12/2015 Detalles del anuncio (526228) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 206, S 8, H PO 2816, I/A 61 (16.12.15).
- Cambio de denominación social
ZELNOVA ZELTIA SA.
28/08/2015 Detalles del anuncio (355076) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 57 (19.08.15).
- Ceses/Dimisiones
Vicesecret.: VENDRELL ARISTE GERARD.
28/08/2015 Detalles del anuncio (355077) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 58 (19.08.15).
- Ceses/Dimisiones
Secretario: CUENCA MIRANDA SEBASTIAN.
- Nombramientos
Secretario: GOMEZ PULIDO JUAN. Vicesecret.: CUENCA MIRANDA SEBASTIAN.
28/08/2015 Detalles del anuncio (355079) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 66, S 8, H PO 2816, I/A 60 (19.08.15).
- Reelecciones
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
28/08/2015 Detalles del anuncio (355078) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 59 (19.08.15).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: JEFPO SL.
- Nombramientos
Consejero: PEREZ ORIVE CARCELLER JOSE FELIX.
11/06/2015 Detalles del anuncio (237539) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 56 ( 5.06.15).
- Nombramientos
Apoderado: MIELGO NUÑEZ LUIS ANGEL.
07/04/2015 Detalles del anuncio (144775) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 55 (26.03.15).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO.
21/11/2014 Detalles del anuncio (476130) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 64, S 8, H PO 2816, I/A 54 (12.11.14).
- Cancelaciones de oficio de nombramientos
Consejero: JEFPO SL.
- Nombramientos
Consejero: JEFPO SL.
14/08/2014 Detalles del anuncio (334601) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 64, S 8, H PO 2816, I/A 53 ( 6.08.14).
- Reelecciones
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
02/08/2013 Detalles del anuncio (347895) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 64, S 8, H PO 2816, I/A 52 (24.07.13).
- Reelecciones
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2015-246-36 | 28/12/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-164-36 | 28/08/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-164-36 | 28/08/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-164-36 | 28/08/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-164-36 | 28/08/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-108-36 | 11/06/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2015-64-36 | 07/04/2015 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2014-223-36 | 21/11/2014 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2014-154-36 | 14/08/2014 | Pontevedra | Descargar |
| BORME-A-2013-146-36 | 02/08/2013 | Pontevedra | Descargar |