ZELNOVA SA

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 28/08/2015

VENDRELL ARISTE GERARD

Vicesecretario
Cese: 28/08/2015

CUENCA MIRANDA SEBASTIAN

Secretario
Nombramiento: 28/08/2015

GOMEZ PULIDO JUAN

Secretario
Nombramiento: 28/08/2015

CUENCA MIRANDA SEBASTIAN

Vicesecretario
Nombramiento: 28/08/2015

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 28/08/2015

JEFPO SL

Consejero
Nombramiento: 28/08/2015

PEREZ ORIVE CARCELLER JOSE FELIX

Consejero
Nombramiento: 11/06/2015

MIELGO NUÑEZ LUIS ANGEL

Apoderado
Cese: 07/04/2015

GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO

Consejero
Cese: 21/11/2014

JEFPO SL

Consejero
Nombramiento: 21/11/2014

JEFPO SL

Consejero
Nombramiento: 14/08/2014

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 02/08/2013

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 14/09/2012

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ZELNOVA SA

28/12/2015 Detalles del anuncio (526228) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 206, S 8, H PO 2816, I/A 61 (16.12.15).

  • Cambio de denominación social

    ZELNOVA ZELTIA SA.

28/08/2015 Detalles del anuncio (355076) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 57 (19.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Vicesecret.: VENDRELL ARISTE GERARD.

28/08/2015 Detalles del anuncio (355077) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 58 (19.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: CUENCA MIRANDA SEBASTIAN.

  • Nombramientos

    Secretario: GOMEZ PULIDO JUAN. Vicesecret.: CUENCA MIRANDA SEBASTIAN.

28/08/2015 Detalles del anuncio (355079) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 66, S 8, H PO 2816, I/A 60 (19.08.15).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

28/08/2015 Detalles del anuncio (355078) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 59 (19.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: JEFPO SL.

  • Nombramientos

    Consejero: PEREZ ORIVE CARCELLER JOSE FELIX.

11/06/2015 Detalles del anuncio (237539) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 56 ( 5.06.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: MIELGO NUÑEZ LUIS ANGEL.

07/04/2015 Detalles del anuncio (144775) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 65, S 8, H PO 2816, I/A 55 (26.03.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO.

21/11/2014 Detalles del anuncio (476130) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 64, S 8, H PO 2816, I/A 54 (12.11.14).

  • Cancelaciones de oficio de nombramientos

    Consejero: JEFPO SL.

  • Nombramientos

    Consejero: JEFPO SL.

14/08/2014 Detalles del anuncio (334601) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 64, S 8, H PO 2816, I/A 53 ( 6.08.14).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

02/08/2013 Detalles del anuncio (347895) Datos registrales: T 1057, L 1057, F 64, S 8, H PO 2816, I/A 52 (24.07.13).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-246-36 28/12/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-164-36 28/08/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-164-36 28/08/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-164-36 28/08/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-164-36 28/08/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-108-36 11/06/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2015-64-36 07/04/2015 Pontevedra Descargar
BORME-A-2014-223-36 21/11/2014 Pontevedra Descargar
BORME-A-2014-154-36 14/08/2014 Pontevedra Descargar
BORME-A-2013-146-36 02/08/2013 Pontevedra Descargar