WEDOIT SOCIEDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL

Extinta

C/ GABRIEL GARCIA MARQUEZ 1, (ROZAS DE MADRID (LAS)).
 Rozas de Madrid, Las, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 26/09/2022

SANCHEZ BENITO SERGIO

Administrador único
Cese: 26/09/2022

MANSO IZQUIERDO SERGIO

Apoderado
Cese: 26/09/2022

MODET ALAMO MARIA DOLORES

Apoderado
Cese: 26/09/2022

SANCHEZ BENITO SERGIO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 26/09/2022

ESPERON CHACEL PALOMA

Apoderado
Cese: 26/09/2022

TOUGAS DENNIS GERARD

Apoderado
Nombramiento: 26/09/2022

SANCHEZ BENITO SERGIO

Liquidador
Cese: 21/04/2022

BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO

Secretario
Cese: 21/04/2022

PRADAS PALENCIA JOSE-MARIA

Representante
Cese: 21/04/2022

JIMENEZ SANCHEZ ROCIO

Representante
Cese: 21/04/2022

PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL

Consejero
Cese: 21/04/2022

VALORACION Y CONTROL SL

Consejero
Cese: 21/04/2022

ARANGUREN ESCOBAR LUIS

Consejero
Cese: 21/04/2022

ARANGUREN ESCOBAR LUIS

Presidente
Cese: 21/04/2022

DIAZ HORTIGON GUILLERMO JESUS

Consejero
Cese: 21/04/2022

SANCHEZ BENITO SERGIO

Consejero
Nombramiento: 21/04/2022

SANCHEZ BENITO SERGIO

Administrador único
Cese: 01/02/2022

CABELLA CRISTINA PAOLA

Apoderado
Cese: 01/02/2022

KRATSCHMER STEFAN THOMAS KURT

Apoderado
Cese: 01/02/2022

CRONIN MICHAEL FITZGERALD

Apoderado
Cese: 01/02/2022

SALZMANN EVA ROSE

Apoderado
Nombramiento: 01/02/2022

TOUGAS DENNIS GERARD

Apoderado
Nombramiento: 24/01/2022

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 03/02/2021

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 29/09/2020

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 04/05/2020

BEJERANO IGLESIA ALBERTO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2020

ESPERON CHACEL PALOMA

Apoderado
Cese: 27/01/2020

JIMENEZ MOLINA JORGE RICARDO

Apoderado
Nombramiento: 27/01/2020

SANCHEZ BENITO SERGIO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 27/12/2019

JIMENEZ MOLINA JORGE RICARDO

Consejero
Nombramiento: 27/12/2019

SANCHEZ BENITO SERGIO

Consejero
Nombramiento: 10/04/2019

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por WEDOIT SOCIEDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL

26/09/2022 Detalles del anuncio (427095) Datos registrales: T 38297 , F 183, S 8, H M 529319, I/A 34 (19.09.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: SANCHEZ BENITO SERGIO.

  • Revocaciones

    Apoderado: MANSO IZQUIERDO SERGIO;MODET ALAMO MARIA DOLORES. Apo.Man.Soli: SANCHEZ BENITO SERGIO. Apoderado: ESPERON CHACEL PALOMA;TOUGAS DENNIS GERARD.

  • Nombramientos

    Liquidador: SANCHEZ BENITO SERGIO.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

21/04/2022 Detalles del anuncio (179924) Datos registrales: T 38297 , F 182, S 8, H M 529319, I/A 33 (12.04.22).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    KYNDRYL ESPAÑA SA.

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: BARREDA VELASCO CARLOS MAXIMILIANO. Representan: PRADAS PALENCIA JOSE-MARIA;JIMENEZ SANCHEZ ROCIO. Consejero: PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL;VALORACION Y CONTROL SL;ARANGUREN ESCOBAR LUIS. Presidente: ARANGUREN ESCOBAR LUIS. Consejero: DIAZ HORTIGON GUILLERMO JESUS;SANCHEZ BENITO SERGIO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SANCHEZ BENITO SERGIO.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

01/02/2022 Detalles del anuncio (45100) Datos registrales: T 38297 , F 181, S 8, H M 529319, I/A 32 (25.01.22).

  • Revocaciones

    Apoderado: CABELLA CRISTINA PAOLA;KRATSCHMER STEFAN THOMAS KURT;CRONIN MICHAEL FITZGERALD;SALZMANN EVA ROSE.

  • Nombramientos

    Apoderado: TOUGAS DENNIS GERARD.

24/01/2022 Detalles del anuncio (30456) Datos registrales: T 38297 , F 181, S 8, H M 529319, I/A 31 (17.01.22).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

03/02/2021 Detalles del anuncio (53166) Datos registrales: T 38297 , F 181, S 8, H M 529319, I/A 30 (28.01.21).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

29/09/2020 Detalles del anuncio (328162) Datos registrales: T 38297 , F 181, S 8, H M 529319, I/A 29 (22.09.20).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

04/05/2020 Detalles del anuncio (151599) Datos registrales: T 38297 , F 179, S 8, H M 529319, I/A 28 (24.04.20).

  • Revocaciones

    Apoderado: BEJERANO IGLESIA ALBERTO.

  • Nombramientos

    Apoderado: ESPERON CHACEL PALOMA.

27/01/2020 Detalles del anuncio (35549) Datos registrales: T 38297 , F 178, S 8, H M 529319, I/A 27 (20.01.20).

  • Revocaciones

    Apoderado: JIMENEZ MOLINA JORGE RICARDO.

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: SANCHEZ BENITO SERGIO.

27/12/2019 Detalles del anuncio (540692) Datos registrales: T 38297 , F 178, S 8, H M 529319, I/A 26 (19.12.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: JIMENEZ MOLINA JORGE RICARDO.

  • Nombramientos

    Consejero: SANCHEZ BENITO SERGIO.

10/04/2019 Detalles del anuncio (161186) Datos registrales: T 38297 , F 178, S 8, H M 529319, I/A 25 ( 3.04.19).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 27

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-184-28 26/09/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-76-28 21/04/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-21-28 01/02/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-15-28 24/01/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-22-28 03/02/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-189-28 29/09/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-84-28 04/05/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2020-17-28 27/01/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-247-28 27/12/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-70-28 10/04/2019 Madrid Descargar