VIVAREGA SL

Activa

CALLE BONASTRUC DE PORTA, 29 - 2N
Girona  (17001)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 14/03/2022

SALVADOR GAMON POLO

Secretario
Cese: 14/03/2022

SALVADOR GAMON POLO

Consejero
Cese: 14/03/2022

BLANCA VERONICA VALLE FERNANDEZ

Consejero
Nombramiento: 14/03/2022

JOSE LUIS VALLE FERNANDEZ

Consejero
Nombramiento: 14/03/2022

ESTANISLAO GAMON POLO

Consejero
Nombramiento: 14/03/2022

EDUARDO FERNANDEZ DE RETANA BERAZADI

Consejero
Nombramiento: 14/03/2022

ESTANISLAO GAMON POLO

Secretario
Cese: 07/12/2016

RAFAEL FERNANDEZ DE RETANA SARACHO

Consejero
Cese: 07/12/2016

RAFAEL FERNANDEZ DE RETANA SARACHO

Presidente
Cese: 07/12/2016

MARIA BLANCA LOPEZ VALLE

Consejero
Nombramiento: 07/12/2016

RAFAEL FERANDEZ DE RETANA MATOSSI

Consejero
Nombramiento: 07/12/2016

RAFAEL FERANDEZ DE RETANA MATOSSI

Presidente
Nombramiento: 07/12/2016

MIGUEL MARIA LOPEZ VALLE

Consejero
Cese: 05/08/2013

MIGUEL MARIA LOPEZ VALLE

Consejero
Nombramiento: 05/08/2013

MARIA BLANCA LOPEZ VALLE

Consejero
Nombramiento: 04/10/2010

ESTANISLAO GAMON POLO

Apoderado
Cese: 01/09/2010

ESTANISLAO GAMON POLO

Administrador solidario
Cese: 01/09/2010

SALVADOR GAMON POLO

Administrador solidario
Nombramiento: 01/09/2010

RAFAEL FERNANDEZ DE RETANA SARACHO

Presidente
Nombramiento: 01/09/2010

SALVADOR GAMON POLO

Secretario
Nombramiento: 01/09/2010

BLANCA VERONICA VALLE FERNANDEZ

Consejero
Nombramiento: 01/09/2010

MARIA LLUISA VILELLA CABALLE

Consejero
Nombramiento: 01/09/2010

MIGUEL MARIA LOPEZ VALLE

Consejero
Nombramiento: 15/04/2010

ESTANISLAO GAMON POLO

Administrador solidario
Nombramiento: 15/04/2010

SALVADOR GAMON POLO

Administrador solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por VIVAREGA SL

11/12/2023 Detalles del anuncio (523566) Datos registrales: T 2773 , F 22, S 8, H GI 49665, I/A 8 (30.11.23).

    14/03/2022 Detalles del anuncio (111377) Datos registrales: T 2773 , F 22, S 8, H GI 49665, I/A 7 ( 7.03.22).

    • Ceses/Dimisiones

      Secretario: SALVADOR GAMON POLO. Consejero: SALVADOR GAMON POLO;BLANCA VERONICA VALLE FERNANDEZ.

    • Nombramientos

      Consejero: JOSE LUIS VALLE FERNANDEZ;ESTANISLAO GAMON POLO;EDUARDO FERNANDEZ DE RETANA BERAZADI. Secretario: ESTANISLAO GAMON POLO.

    07/12/2016 Detalles del anuncio (493716) Datos registrales: T 2773 , F 22, S 8, H GI 49665, I/A 6 (29.11.16).

    • Ceses/Dimisiones

      Consejero: RAFAEL FERNANDEZ DE RETANA SARACHO. Presidente: RAFAEL FERNANDEZ DE RETANA SARACHO. Consejero: MARIA BLANCA LOPEZ VALLE.

    • Nombramientos

      Consejero: RAFAEL FERANDEZ DE RETANA MATOSSI. Presidente: RAFAEL FERANDEZ DE RETANA MATOSSI. Consejero: MIGUEL MARIA LOPEZ VALLE.

    05/08/2013 Detalles del anuncio (349347) Datos registrales: T 2773 , F 22, S 8, H GI 49665, I/A 5 (29.07.13).

    • Ceses/Dimisiones

      Consejero: MIGUEL MARIA LOPEZ VALLE.

    • Nombramientos

      Consejero: MARIA BLANCA LOPEZ VALLE.

    02/04/2013 Detalles del anuncio (152062) Datos registrales: T 2773 , F 22, S 8, H GI 49665, I/A 4 (22.03.13).

    • Ampliación de Capital

      Capital: 236.195,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.660.370,00 Euros.

    13/07/2011 Detalles del anuncio (205002)

    • Depósitos de cuentas anuales

      (Julio de 2011) Año: 2010

    04/10/2010 Detalles del anuncio (370465) Datos registrales: T 2773 , F 21, S 8, H GI 49665, I/A 3 (23.09.10).

    • Nombramientos

      Apoderado: ESTANISLAO GAMON POLO.

    01/09/2010 Detalles del anuncio (337240) Datos registrales: T 2773 , F 19, S 8, H GI 49665, I/A 2 (18.08.10).

    • Ceses/Dimisiones

      Adm. Solid.: ESTANISLAO GAMON POLO;SALVADOR GAMON POLO.

    • Nombramientos

      Presidente: RAFAEL FERNANDEZ DE RETANA SARACHO. Secretario: SALVADOR GAMON POLO. Consejero: BLANCA VERONICA VALLE FERNANDEZ;MARIA LLUISA VILELLA CABALLE;MIGUEL MARIA LOPEZ VALLE.

    • Ampliación de Capital

      Capital: 9.420.945,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.424.175,00 Euros.

    • Modificaciones Estatutarias

      Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración.

    15/04/2010 Detalles del anuncio (150134) Datos registrales: T 2773 , F 19, S 8, H GI 49665, I/A 1 ( 1.04.10).

    • Constitución

      Comienzo de operaciones: 12.03.10. Objeto social: Construcción de hoteles, moteles, hostales, albergues, paradores, restaurantes, bares y salas de fiestas, ya sea para su explotación directa, para suenajenación o para su cesión en arrendamiento. Domicilio: C/ BONASTRUC DE PORTA 29 2 (GIRONA). Capital: 3.230,00 Euros.

    • Nombramientos

      Adm. Solid.: ESTANISLAO GAMON POLO;SALVADOR GAMON POLO.

    Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9

    #CVE
    Fecha
    Provincia
    BORME-A-2023-233-17 11/12/2023 Girona Descargar
    BORME-A-2022-50-17 14/03/2022 Girona Descargar
    BORME-A-2016-232-17 07/12/2016 Girona Descargar
    BORME-A-2013-147-17 05/08/2013 Girona Descargar
    BORME-A-2013-61-17 02/04/2013 Girona Descargar
    BORME-B-2011-133-17 13/07/2011 Girona Descargar
    BORME-A-2010-191-17 04/10/2010 Girona Descargar
    BORME-A-2010-168-17 01/09/2010 Girona Descargar
    BORME-A-2010-70-17 15/04/2010 Girona Descargar