VIMODESARROLLOS SL

Activa

CL DOCTOR CARULLA,40-42 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 11/12/2014

ENCINA LOS MONTEROS SL

Administrador conjunto
Cese: 11/12/2014

FERNANDEZ MAS ALEJANDRO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 15/01/2014

VIDAL PLANAS FERMIN

Secretario no consejero
Cese: 15/01/2014

FUNEZ SOBABERAS MARC

Consejero
Cese: 15/01/2014

VIDAL PLANAS FERMIN

Consejero
Cese: 15/01/2014

VIDAL PLANAS FERMIN

Consejero delegado
Cese: 15/01/2014

FUNEZ SOBABERAS MARC

Presidente
Nombramiento: 15/01/2014

ENCINA LOS MONTEROS SL

Administrador conjunto
Nombramiento: 15/01/2014

FERNANDEZ MAS ALEJANDRO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 15/01/2014

VIDAL PLANAS FERMIN

Administrador conjunto
Cese: 11/12/2012

MEDINA MIGUEL ELENA

Consejero
Cese: 07/12/2011

VILALLONGA SHELLY DAVID

Consejero
Cese: 07/12/2011

VILALLONGA SHELLY DAVID

Presidente
Cese: 07/12/2011

MOULINES DOBON ENRIQUE

Consejero
Cese: 07/12/2011

MOULINES DOBON ENRIQUE

Consejero delegado
Cese: 07/12/2011

CANTALLOPS GUAL ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 07/12/2011

VIDAL PLANAS FERMIN

Consejero
Nombramiento: 07/12/2011

VIDAL PLANAS FERMIN

Consejero delegado
Nombramiento: 07/12/2011

FUNEZ SOBABERAS MARC

Presidente
Cese: 26/09/2011

OLIVER ROCA RAFAEL GERARDO

Consejero
Nombramiento: 26/09/2011

MEDINA MIGUEL ELENA

Consejero
Nombramiento: 26/11/2009

FUNEZ SOBABERAS MARC

Consejero
Cese: 10/07/2009

ALLES CAMPS OSCAR

Secretario no consejero
Nombramiento: 10/07/2009

VIDAL PLANAS FERMIN

Secretario no consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por VIMODESARROLLOS SL

11/12/2014 Detalles del anuncio (504246) Datos registrales: T 38192 , F 105, S 8, H B 304187, I/A 15 ( 3.12.14).

  • Revocaciones

    ADM.CONJUNTO: ENCINA LOS MONTEROS SL. REPR.143 RRM: FERNANDEZ MAS ALEJANDRO.

15/01/2014 Detalles del anuncio (13925) Datos registrales: T 38192 , F 105, S 8, H B 304187, I/A 14 ( 8.01.14).

  • Revocaciones

    SECR.NO CONS: VIDAL PLANAS FERMIN. CONSEJERO: FUNEZ SOBABERAS MARC;VIDAL PLANAS FERMIN. CONS. DELEG.: VIDAL PLANAS FERMIN. PRESIDENTE: FUNEZ SOBABERAS MARC.

  • Nombramientos

    ADM.CONJUNTO: ENCINA LOS MONTEROS SL. REPR.143 RRM: FERNANDEZ MAS ALEJANDRO. ADM.CONJUNTO: VIDAL PLANAS FERMIN.

11/12/2012 Detalles del anuncio (510852) Datos registrales: T 38192 , F 105, S 8, H B 304187, I/A 13 (30.11.12).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: MEDINA MIGUEL ELENA.

23/01/2012 Detalles del anuncio (13697)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2011) Año: 2010

07/12/2011 Detalles del anuncio (486489) Datos registrales: T 38192 , F 104, S 8, H B 304187, I/A 12 (23.11.11).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: VILALLONGA SHELLY DAVID. PRESIDENTE: VILALLONGA SHELLY DAVID. CONSEJERO: MOULINES DOBON ENRIQUE. CONS. DELEG.: MOULINES DOBON ENRIQUE. CONSEJERO: CANTALLOPS GUAL ANTONIO.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: VIDAL PLANAS FERMIN. CONS. DELEG.: VIDAL PLANAS FERMIN. PRESIDENTE: FUNEZ SOBABERAS MARC.

26/09/2011 Detalles del anuncio (384167) Datos registrales: T 38192 , F 104, S 8, H B 304187, I/A 11 (15.09.11).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: OLIVER ROCA RAFAEL GERARDO.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: MEDINA MIGUEL ELENA.

25/08/2010 Detalles del anuncio (374493)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2010) Año: 2009

22/06/2010 Detalles del anuncio (247390) Datos registrales: T 38192 , F 104, S 8, H B 304187, I/A 10 (10.06.10).

  • Cambio de objeto social

    LA ACTIVIDAD DE PROMOCION INMOBILIARIA.

18/01/2010 Detalles del anuncio (15269) Datos registrales: T 38192 , F 103, S 8, H B 304187, I/A 9 ( 5.01.10).

  • Cambio de domicilio social

    CL DOCTOR CARULLA,40-42 (BARCELONA).

26/11/2009 Detalles del anuncio (494552) Datos registrales: T 38192 , F 103, S 8, H B 304187, I/A 8 (16.11.09).

  • Nombramientos

    CONSEJERO: FUNEZ SOBABERAS MARC.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2014-236-08 11/12/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-9-08 15/01/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-236-08 11/12/2012 Barcelona Descargar
BORME-B-2012-15-08 23/01/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-231-08 07/12/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-183-08 26/09/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-163-08 25/08/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-117-08 22/06/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-10-08 18/01/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-226-08 26/11/2009 Barcelona Descargar