VEBLINTER SA

Activa

CALLE MONTESA, 2-4-6-8
 Loeches, Madrid  (28890)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 16/09/2022

EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL

Auditor
Nombramiento: 05/08/2019

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Administrador único
Nombramiento: 20/01/2014

A&G PRACTICA MERCANTIL SOCIEDAD LIMITADA

Auditor
Cese: 27/09/2013

AMARO GENER JOSE MANUEL

Consejero
Cese: 27/09/2013

AMARO GENER JOSE MANUEL

Presidente
Cese: 27/09/2013

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Consejero
Cese: 27/09/2013

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Secretario
Cese: 27/09/2013

MONFORTE BLAZQUEZ JOSE ANTONIO

Consejero
Cese: 27/09/2013

AMARO GENER JOSE MANUEL

Consejero delegado mancomunado solidario
Cese: 27/09/2013

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 27/09/2013

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Administrador único
Nombramiento: 16/08/2012

AMARO GENER JOSE MANUEL

Consejero
Nombramiento: 16/08/2012

AMARO GENER JOSE MANUEL

Presidente
Nombramiento: 16/08/2012

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Consejero
Nombramiento: 16/08/2012

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Secretario
Nombramiento: 16/08/2012

MONFORTE BLAZQUEZ JOSE ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 16/08/2012

AMARO GENER JOSE MANUEL

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 16/08/2012

MORALES DEL CASTILLO MANUEL

Consejero delegado mancomunado solidario
Nombramiento: 27/02/2012

AUDYCO AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 03/03/2011

AUDYCO AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 23/07/2010

AGUERA MARIN BENITO

Auditor
Nombramiento: 11/12/2009

RODRIGUEZ ALCANTARA JACINTO

Auditor
Nombramiento: 27/03/2009

BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por VEBLINTER SA

16/09/2022 Detalles del anuncio (417872) Datos registrales: T 31446 , F 204, S 8, H M 108144, I/A 19 (10.09.22).

  • Nombramientos

    Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL.

05/08/2019 Detalles del anuncio (341676) Datos registrales: T 31446 , F 203, S 8, H M 108144, I/A 18 (29.07.19).

  • Reelecciones

    Adm. Unico: MORALES DEL CASTILLO MANUEL.

10/07/2015 Detalles del anuncio (284269) Datos registrales: T 31446 , F 201, S 8, H M 108144, I/A 17 ( 3.07.15).

  • Modificaciones Estatutarias

    Modificados los estatutos sociales.

20/01/2014 Detalles del anuncio (24222) Datos registrales: T 13257 , F 218, S 8, H M 108144, I/A 16 (13.01.14).

  • Reelecciones

    Auditor: A&G PRACTICA MERCANTIL SOCIEDAD LIMITADA.

27/09/2013 Detalles del anuncio (416047) Datos registrales: T 13257 , F 218, S 8, H M 108144, I/A 15 (18.09.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: AMARO GENER JOSE MANUEL. Presidente: AMARO GENER JOSE MANUEL. Consejero: MORALES DEL CASTILLO MANUEL. Secretario: MORALES DEL CASTILLO MANUEL. Consejero: MONFORTE BLAZQUEZ JOSE ANTONIO. Co.De.Ma.So: AMARO GENER JOSE MANUEL;MORALES DEL CASTILLO MANUEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: MORALES DEL CASTILLO MANUEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.Modificación de los artículos 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23y 24º de los estatutos sociales..

23/08/2013 Detalles del anuncio (374816) Datos registrales: T 13257 , F 217, S 8, H M 108144, I/A 14 (13.08.13).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 15.652,00 Euros. Resultante Suscrito: 44.548,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 15.652,00 Euros. Desembolsado: 15.652,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.200,00 Euros. Resultante Desembolsado: 60.200,00 Euros.

16/08/2012 Detalles del anuncio (343916) Datos registrales: T 13257 , F 217, S 8, H M 108144, I/A 13 ( 3.08.12).

  • Reelecciones

    Consejero: AMARO GENER JOSE MANUEL. Presidente: AMARO GENER JOSE MANUEL. Consejero: MORALES DEL CASTILLO MANUEL. Secretario: MORALES DEL CASTILLO MANUEL. Consejero: MONFORTE BLAZQUEZ JOSE ANTONIO. Co.De.Ma.So: AMARO GENER JOSE MANUEL;MORALES DEL CASTILLO MANUEL.

27/02/2012 Detalles del anuncio (94212) Datos registrales: T 13257 , F 216, S 8, H M 108144, I/A 12 (15.02.12).

  • Nombramientos

    Auditor: AUDYCO AUDITORES SL.

07/10/2011 Detalles del anuncio (744458)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

15/04/2011 Detalles del anuncio (131616)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Marzo de 2011) Año: 2009

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-178-28 16/09/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2019-148-28 05/08/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2015-129-28 10/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-12-28 20/01/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-185-28 27/09/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-160-28 23/08/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-156-28 16/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-40-28 27/02/2012 Madrid Descargar
BORME-B-2011-192-28 07/10/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2011-74-28 15/04/2011 Madrid Descargar