URCOBAR SL

Activa

C/ ASTRONOMIA 1 11 - TORRE 5, MODULOS 7 AL 12 (SEVILLA).
Sevilla
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 17/08/2022

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Secretario
Cese: 17/08/2022

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Consejero
Cese: 17/08/2022

ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES

Consejero delegado mancomunado
Cese: 17/08/2022

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Consejero delegado mancomunado
Cese: 17/08/2022

VILLENA CONTRERAS LUIS

Consejero delegado mancomunado
Cese: 17/08/2022

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 17/08/2022

DE MEDINA IGLESIAS JUAN ANDRES

Apoderado
Nombramiento: 17/08/2022

MONTULL BURILLO ALEJANDRO

Consejero
Nombramiento: 17/08/2022

MONTULL BURILLO ALEJANDRO

Secretario
Nombramiento: 17/08/2022

VILLENA CONTRERAS LUIS

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 17/08/2022

ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 17/08/2022

MONTULL BURILLO ALEJANDRO

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 17/08/2022

VILLENA CONTRERAS LUIS

Presidente
Nombramiento: 10/11/2020

GIL BALAGUERO JORDI

Apoderado
Nombramiento: 23/10/2019

PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS

Apoderado
Cese: 26/11/2015

ROSA BARBA FERNANDO

Consejero
Cese: 26/11/2015

ROSA BARBA FERNANDO

Presidente
Cese: 26/11/2015

ROSA TORRES ANGELA

Consejero
Cese: 26/11/2015

ROSA TORRES ANGELA

Secretario
Cese: 26/11/2015

ROSA TORRES ANGELA

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/11/2015

PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS

Consejero
Cese: 26/11/2015

PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/11/2015

ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE

Consejero
Cese: 26/11/2015

ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/11/2015

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Consejero
Cese: 26/11/2015

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Vicesecretario
Cese: 26/11/2015

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/11/2015

VILLENA CONTRERAS LUIS

Consejero
Cese: 26/11/2015

VILLENA CONTRERAS LUIS

Vicepresidente
Nombramiento: 26/11/2015

VILLENA CONTRERAS LUIS

Consejero
Nombramiento: 26/11/2015

VILLENA CONTRERAS LUIS

Presidente
Nombramiento: 26/11/2015

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Consejero
Nombramiento: 26/11/2015

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Secretario
Nombramiento: 26/11/2015

ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES

Consejero
Nombramiento: 26/11/2015

ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 26/11/2015

GIL SANCHEZ LUIS MANUEL

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 26/11/2015

VILLENA CONTRERAS LUIS

Consejero delegado mancomunado
Cese: 30/09/2010

AIGE SANCHEZ RAMON

Vicepresidente
Nombramiento: 30/09/2010

VILLENA CONTRERAS LUIS

Consejero
Nombramiento: 30/09/2010

VILLENA CONTRERAS LUIS

Vicepresidente

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por URCOBAR SL

17/08/2022 Detalles del anuncio (380433) Datos registrales: T 6209 , F 221, S 8, H SE110527, I/A 7 ( 5.08.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Consejero: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Cons.Del.Man: ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES;GIL SANCHEZ LUIS MANUEL;VILLENA CONTRERAS LUIS.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: DE MEDINA IGLESIAS JUAN ANDRES. Consejero: MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Secretario: MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Cons.Del.Man: VILLENA CONTRERAS LUIS;ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES;MONTULL BURILLO ALEJANDRO.

  • Reelecciones

    Presidente: VILLENA CONTRERAS LUIS.

  • Otros Conceptos

    REVOCADO el poder NO INSCRITO otorgados a favor de D. Fernando Carlos Peña Expósito en escritura autorizada en fecha 16 de septiembre de 2019 por el Notario del Ilustre Colegio de Catalunya D. Pablo Gómez Clavería, número 5139 de su protocolo.-

10/11/2020 Detalles del anuncio (385240) Datos registrales: T 6209 , F 221, S 8, H SE110527, I/A 6 (30.10.20).

  • Nombramientos

    Apoderado: GIL BALAGUERO JORDI.

23/10/2019 Detalles del anuncio (440184) Datos registrales: T 6209 , F 220, S 8, H SE110527, I/A 5 (15.10.19).

  • Nombramientos

    Apoderado: PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS.

16/08/2016 Detalles del anuncio (338112) Datos registrales: T 6209 , F 218, S 8, H SE110527, I/A 2 ( 3.08.16).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social y web corporativa.-.

  • Cambio de domicilio social

    C/ ASTRONOMIA 1 11 - TORRE 5, MODULOS 7 AL 12 (SEVILLA).

26/11/2015 Detalles del anuncio (479344) Datos registrales: T 1809 , F 87, S 8, H CO 21966, I/A 4 (19.11.15).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ROSA BARBA FERNANDO. Presidente: ROSA BARBA FERNANDO. Consejero: ROSA TORRES ANGELA. Secretario: ROSA TORRES ANGELA. Cons.Del.Man: ROSA TORRES ANGELA. Consejero: PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS. Cons.Del.Man: PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS. Consejero: ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE. Cons.Del.Man: ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE. Consejero: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Vicesecret.: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Cons.Del.Man: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Consejero: VILLENA CONTRERAS LUIS. Vicepresid.: VILLENA CONTRERAS LUIS.

  • Nombramientos

    Consejero: VILLENA CONTRERAS LUIS. Presidente: VILLENA CONTRERAS LUIS. Consejero: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Secretario: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Consejero: ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES. Cons.Del.Man: ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES;GIL SANCHEZ LUIS MANUEL;VILLENA CONTRERAS LUIS.

16/08/2011 Detalles del anuncio (286555)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2010

30/09/2010 Detalles del anuncio (367206) Datos registrales: T 1809 , F 86, S 8, H CO 21966, I/A 3 (21.09.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Vicepresid.: AIGE SANCHEZ RAMON.

  • Nombramientos

    Consejero: VILLENA CONTRERAS LUIS. Vicepresid.: VILLENA CONTRERAS LUIS.

09/08/2010 Detalles del anuncio (289146)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2010) Año: 2009

12/08/2009 Detalles del anuncio (206363)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2009) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-156-41 17/08/2022 Sevilla Descargar
BORME-A-2020-216-41 10/11/2020 Sevilla Descargar
BORME-A-2019-204-41 23/10/2019 Sevilla Descargar
BORME-A-2016-155-41 16/08/2016 Sevilla Descargar
BORME-A-2015-226-14 26/11/2015 Córdoba Descargar
BORME-B-2011-155-14 16/08/2011 Córdoba Descargar
BORME-A-2010-189-14 30/09/2010 Córdoba Descargar
BORME-B-2010-151-14 09/08/2010 Córdoba Descargar
BORME-B-2009-152-14 12/08/2009 Córdoba Descargar