URCOBAR SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 17/08/2022 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Secretario |
| Cese: 17/08/2022 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Consejero |
| Cese: 17/08/2022 | ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 17/08/2022 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 17/08/2022 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 17/08/2022 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 17/08/2022 | DE MEDINA IGLESIAS JUAN ANDRES |
Apoderado |
| Nombramiento: 17/08/2022 | MONTULL BURILLO ALEJANDRO |
Consejero |
| Nombramiento: 17/08/2022 | MONTULL BURILLO ALEJANDRO |
Secretario |
| Nombramiento: 17/08/2022 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 17/08/2022 | ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 17/08/2022 | MONTULL BURILLO ALEJANDRO |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 17/08/2022 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Presidente |
| Nombramiento: 10/11/2020 | GIL BALAGUERO JORDI |
Apoderado |
| Nombramiento: 23/10/2019 | PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS |
Apoderado |
| Cese: 26/11/2015 | ROSA BARBA FERNANDO |
Consejero |
| Cese: 26/11/2015 | ROSA BARBA FERNANDO |
Presidente |
| Cese: 26/11/2015 | ROSA TORRES ANGELA |
Consejero |
| Cese: 26/11/2015 | ROSA TORRES ANGELA |
Secretario |
| Cese: 26/11/2015 | ROSA TORRES ANGELA |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 26/11/2015 | PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS |
Consejero |
| Cese: 26/11/2015 | PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 26/11/2015 | ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE |
Consejero |
| Cese: 26/11/2015 | ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 26/11/2015 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Consejero |
| Cese: 26/11/2015 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Vicesecretario |
| Cese: 26/11/2015 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 26/11/2015 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Consejero |
| Cese: 26/11/2015 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 26/11/2015 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 26/11/2015 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Presidente |
| Nombramiento: 26/11/2015 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Consejero |
| Nombramiento: 26/11/2015 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Secretario |
| Nombramiento: 26/11/2015 | ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES |
Consejero |
| Nombramiento: 26/11/2015 | ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 26/11/2015 | GIL SANCHEZ LUIS MANUEL |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 26/11/2015 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 30/09/2010 | AIGE SANCHEZ RAMON |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 30/09/2010 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 30/09/2010 | VILLENA CONTRERAS LUIS |
Vicepresidente |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por URCOBAR SL
17/08/2022 Detalles del anuncio (380433) Datos registrales: T 6209 , F 221, S 8, H SE110527, I/A 7 ( 5.08.22).
- Ceses/Dimisiones
Secretario: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Consejero: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Cons.Del.Man: ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES;GIL SANCHEZ LUIS MANUEL;VILLENA CONTRERAS LUIS.
- Revocaciones
Apo.Sol.: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL.
- Nombramientos
Apoderado: DE MEDINA IGLESIAS JUAN ANDRES. Consejero: MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Secretario: MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Cons.Del.Man: VILLENA CONTRERAS LUIS;ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES;MONTULL BURILLO ALEJANDRO.
- Reelecciones
Presidente: VILLENA CONTRERAS LUIS.
- Otros Conceptos
REVOCADO el poder NO INSCRITO otorgados a favor de D. Fernando Carlos Peña Expósito en escritura autorizada en fecha 16 de septiembre de 2019 por el Notario del Ilustre Colegio de Catalunya D. Pablo Gómez Clavería, número 5139 de su protocolo.-
10/11/2020 Detalles del anuncio (385240) Datos registrales: T 6209 , F 221, S 8, H SE110527, I/A 6 (30.10.20).
- Nombramientos
Apoderado: GIL BALAGUERO JORDI.
23/10/2019 Detalles del anuncio (440184) Datos registrales: T 6209 , F 220, S 8, H SE110527, I/A 5 (15.10.19).
- Nombramientos
Apoderado: PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS.
16/08/2016 Detalles del anuncio (338112) Datos registrales: T 6209 , F 218, S 8, H SE110527, I/A 2 ( 3.08.16).
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social y web corporativa.-.
- Cambio de domicilio social
C/ ASTRONOMIA 1 11 - TORRE 5, MODULOS 7 AL 12 (SEVILLA).
26/11/2015 Detalles del anuncio (479344) Datos registrales: T 1809 , F 87, S 8, H CO 21966, I/A 4 (19.11.15).
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.
- Ceses/Dimisiones
Consejero: ROSA BARBA FERNANDO. Presidente: ROSA BARBA FERNANDO. Consejero: ROSA TORRES ANGELA. Secretario: ROSA TORRES ANGELA. Cons.Del.Man: ROSA TORRES ANGELA. Consejero: PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS. Cons.Del.Man: PEÑA EXPOSITO FERNANDO CARLOS. Consejero: ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE. Cons.Del.Man: ILLANA CASTILLA MANUEL JOSE. Consejero: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Vicesecret.: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Cons.Del.Man: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Consejero: VILLENA CONTRERAS LUIS. Vicepresid.: VILLENA CONTRERAS LUIS.
- Nombramientos
Consejero: VILLENA CONTRERAS LUIS. Presidente: VILLENA CONTRERAS LUIS. Consejero: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Secretario: GIL SANCHEZ LUIS MANUEL. Consejero: ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES. Cons.Del.Man: ZAYAS FERNANDEZ CORDOBA MOLERO ANDRES;GIL SANCHEZ LUIS MANUEL;VILLENA CONTRERAS LUIS.
16/08/2011 Detalles del anuncio (286555)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2011) Año: 2010
30/09/2010 Detalles del anuncio (367206) Datos registrales: T 1809 , F 86, S 8, H CO 21966, I/A 3 (21.09.10).
- Ceses/Dimisiones
Vicepresid.: AIGE SANCHEZ RAMON.
- Nombramientos
Consejero: VILLENA CONTRERAS LUIS. Vicepresid.: VILLENA CONTRERAS LUIS.
09/08/2010 Detalles del anuncio (289146)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2010) Año: 2009
12/08/2009 Detalles del anuncio (206363)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2009) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-156-41 | 17/08/2022 | Sevilla | Descargar |
| BORME-A-2020-216-41 | 10/11/2020 | Sevilla | Descargar |
| BORME-A-2019-204-41 | 23/10/2019 | Sevilla | Descargar |
| BORME-A-2016-155-41 | 16/08/2016 | Sevilla | Descargar |
| BORME-A-2015-226-14 | 26/11/2015 | Córdoba | Descargar |
| BORME-B-2011-155-14 | 16/08/2011 | Córdoba | Descargar |
| BORME-A-2010-189-14 | 30/09/2010 | Córdoba | Descargar |
| BORME-B-2010-151-14 | 09/08/2010 | Córdoba | Descargar |
| BORME-B-2009-152-14 | 12/08/2009 | Córdoba | Descargar |