TS SYSTEMATIC STRATEGIES SICAV SA

Extinta

PASEO DE LA CASTELLANA, 29 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 21/11/2022

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D

Entidad gestora
Cese: 21/11/2022

SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO

Entidad reg. cont.
Cese: 21/11/2022

BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA

Entidad depositaria
Cese: 21/11/2022

FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO

Vicesecretario
Cese: 21/11/2022

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 21/11/2022

GARCIA PACHES ISMAEL- GASPAR

Secretario
Cese: 21/11/2022

GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR

Consejero
Cese: 21/11/2022

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Consejero
Cese: 21/11/2022

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Presidente
Cese: 21/11/2022

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Consejero delegado
Cese: 21/11/2022

GARCIA PACHES INMACULADA

Consejero
Nombramiento: 21/11/2022

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Liquidador
Cese: 19/04/2022

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Presidente
Cese: 19/04/2022

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Consejero
Cese: 19/04/2022

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 19/04/2022

GARCIA PACHES INMACULADA

Consejero
Nombramiento: 19/04/2022

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Presidente
Nombramiento: 19/04/2022

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Consejero delegado
Nombramiento: 12/11/2021

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Presidente
Nombramiento: 12/11/2021

GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR

Secretario
Nombramiento: 12/11/2021

GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR

Consejero
Nombramiento: 12/11/2021

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 12/11/2021

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 12/11/2021

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Consejero
Cese: 17/10/2019

FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO

Consejero
Nombramiento: 17/10/2019

PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION

Consejero
Nombramiento: 17/10/2019

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 10/08/2016

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 10/08/2016

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 27/07/2015

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 27/07/2015

GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR

Consejero
Nombramiento: 27/07/2015

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 27/07/2015

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Cese: 27/07/2015

SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES

Entidad reg. cont.
Nombramiento: 27/07/2015

SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO

Entidad reg. cont.
Cese: 24/04/2014

DAYARAM IDNANI RAHUL HARIRAM

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 24/04/2014

FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO

Vicesecretario
Cese: 07/05/2013

MADRID GIL CLAUDIA

Consejero
Nombramiento: 07/05/2013

FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO

Consejero
Cese: 11/10/2012

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 11/10/2012

GARCIA CORDOBA FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 11/10/2012

DELOITTE SL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por TS SYSTEMATIC STRATEGIES SICAV SA

21/11/2022 Detalles del anuncio (508474) Datos registrales: T 22678 , F 54, S 8, H M 405644, I/A 28 (14.11.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Ent. Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. EntidDeposit: BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA. Vicesecret.: FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Secretario: GARCIA PACHES ISMAEL- GASPAR. Consejero: GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR;PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION. Presidente: PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION. Con.Delegado: PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION. Consejero: GARCIA PACHES INMACULADA.

  • Nombramientos

    Liquidador: PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

15/09/2022 Detalles del anuncio (416670) Datos registrales: T 22678 , F 54, S 8, H M 405644, I/A 27 ( 8.09.22).

  • Otros Conceptos

    Ratificado por la Junta General celebrada el día 24 de junio de 2022 y por plazo de 6 años, el nombramiento por cooptación de doña Inmaculada García Paredes, como consejera de la Sociedad que fue acordado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 28 de septiembre de 2021.

19/04/2022 Detalles del anuncio (174434) Datos registrales: T 22678 , F 53, S 8, H M 405644, I/A 26 ( 8.04.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: GARCIA CORDOBA FRANCISCO. Consejero: GARCIA CORDOBA FRANCISCO. Cons.Del.Sol: GARCIA CORDOBA FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Consejero: GARCIA PACHES INMACULADA. Presidente: PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION. Con.Delegado: PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION.

12/11/2021 Detalles del anuncio (491181) Datos registrales: T 22678 , F 53, S 8, H M 405644, I/A 25 ( 3.11.21).

  • Reelecciones

    Presidente: GARCIA CORDOBA FRANCISCO. Secretario: GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR. Consejero: GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR;GARCIA CORDOBA FRANCISCO. Cons.Del.Sol: GARCIA CORDOBA FRANCISCO. Consejero: PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION.

17/10/2019 Detalles del anuncio (432022) Datos registrales: T 22678 , F 52, S 8, H M 405644, I/A 24 (10.10.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO.

  • Nombramientos

    Consejero: PACHES MARTINEZ MARIA-ENCARNACION.

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

01/06/2018 Detalles del anuncio (232666) Datos registrales: T 22678 , F 52, S 8, H M 405644, I/A 23 (25.05.18).

  • Modificaciones Estatutarias

    Se incorpora el artículo 15 bis a los estatutos sociales.

10/08/2016 Detalles del anuncio (331623) Datos registrales: T 22678 , F 52, S 8, H M 405644, I/A 22 ( 1.08.16).

  • Revocaciones

    Auditor: DELOITTE SL.

  • Nombramientos

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

27/07/2015 Detalles del anuncio (309072) Datos registrales: T 22678 , F 51, S 8, H M 405644, I/A 21 (17.07.15).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL. Consejero: GARCIA PACHES ISMAEL-GASPAR;GARCIA CORDOBA FRANCISCO. Cons.Del.Sol: GARCIA CORDOBA FRANCISCO.

27/07/2015 Detalles del anuncio (309071) Datos registrales: T 22678 , F 51, S 8, H M 405644, I/A 20 (17.07.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Ent.Reg.Cont: SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES.

  • Nombramientos

    Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO.

24/04/2014 Detalles del anuncio (178431) Datos registrales: T 22678 , F 51, S 8, H M 405644, I/A 19 (14.04.14).

  • Ceses/Dimisiones

    VsecrNoConsj: DAYARAM IDNANI RAHUL HARIRAM.

  • Nombramientos

    Vicesecret.: FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 23

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-221-28 21/11/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-177-28 15/09/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-74-28 19/04/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-217-28 12/11/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2019-200-28 17/10/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-104-28 01/06/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2016-152-28 10/08/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-140-28 27/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-140-28 27/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-78-28 24/04/2014 Madrid Descargar