TRIDEFUS SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
Fecha
|
Nombre
|
|
---|---|---|
Nombramiento: 01/04/2015 | CALZADA BALCELLS MATEO JUAN |
Administrador único |
Nombramiento: 01/04/2015 | MESTRES SUREDA MARIA |
Apoderado solidario |
Cese: 24/02/2015 | VERGES BARTOLI JOAN |
Administrador único |
Cese: 03/09/2014 | SERVIAL OBRES I SERVEIS SL |
Administrador único |
Cese: 03/09/2014 | TARRES COSTA ELOI |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Nombramiento: 03/09/2014 | VERGES BARTOLI JOAN |
Administrador único |
Cese: 04/04/2014 | ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL |
Administrador único |
Cese: 04/04/2014 | CLEMENTE ORTEGO GONZALO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Nombramiento: 04/04/2014 | SERVIAL OBRES I SERVEIS SL |
Administrador único |
Nombramiento: 04/04/2014 | TARRES COSTA ELOI |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Cese: 31/01/2014 | MORA SAGUES BONAVENTURA |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Nombramiento: 31/01/2014 | CLEMENTE ORTEGO GONZALO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Nombramiento: 15/04/2013 | FONTIVEROS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER |
Apoderado |
Nombramiento: 19/10/2012 | GIL MAÑERO XAVIER |
Apoderado |
Cese: 09/10/2012 | TARRES COSTA ELOI |
Administrador único |
Nombramiento: 09/10/2012 | ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL |
Administrador único |
Nombramiento: 09/10/2012 | MORA SAGUES BONAVENTURA |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Nombramiento: 11/05/2010 | CAZADOR PUIG AMADEU |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por TRIDEFUS SL
01/04/2015 Detalles del anuncio (138810) Datos registrales: T 43402 , F 204, S 8, H B 288554, I/A 12 (25.03.15).
- Nombramientos
ADM.UNICO: CALZADA BALCELLS MATEO JUAN.
01/04/2015 Detalles del anuncio (138811) Datos registrales: T 43402 , F 204, S 8, H B 288554, I/A 13 (25.03.15).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: MESTRES SUREDA MARIA.
24/02/2015 Detalles del anuncio (79916) Datos registrales: T 43402 , F 204, S 8, H B 288554, I/A 11 (16.02.15).
- Revocaciones
ADM.UNICO: VERGES BARTOLI JOAN.
03/09/2014 Detalles del anuncio (353492) Datos registrales: T 43402 , F 203, S 8, H B 288554, I/A 10 (27.08.14).
- Revocaciones
ADM.UNICO: SERVIAL OBRES I SERVEIS SL. REPR.143 RRM: TARRES COSTA ELOI.
- Nombramientos
ADM.UNICO: VERGES BARTOLI JOAN.
- Otros Conceptos
SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: CBA HORMIGONES 2009 SL.
- Cambio de domicilio social
CR DE TERRASSA A RUBI Num.314 (TERRASSA).
04/04/2014 Detalles del anuncio (150952) Datos registrales: T 43402 , F 203, S 8, H B 288554, I/A 9 (28.03.14).
- Revocaciones
ADM.UNICO: ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL. REPR.143 RRM: CLEMENTE ORTEGO GONZALO.
- Nombramientos
ADM.UNICO: SERVIAL OBRES I SERVEIS SL. REPR.143 RRM: TARRES COSTA ELOI.
- Cambio de domicilio social
CL CERVERA,11,POL.INDUSTRIAL PLA DE LA BRUGUERA (CASTELLAR DEL VALLES).
31/01/2014 Detalles del anuncio (45442) Datos registrales: T 43402 , F 203, S 8, H B 288554, I/A 8 (23.01.14).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: MORA SAGUES BONAVENTURA.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: CLEMENTE ORTEGO GONZALO.
15/04/2013 Detalles del anuncio (174788) Datos registrales: T 43402 , F 202, S 8, H B 288554, I/A 7 ( 5.04.13).
- Nombramientos
APODERADO: FONTIVEROS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER.
19/10/2012 Detalles del anuncio (424837) Datos registrales: T 43402 , F 201, S 8, H B 288554, I/A 6 ( 8.10.12).
- Nombramientos
APODERADO: GIL MAÑERO XAVIER.
09/10/2012 Detalles del anuncio (411407) Datos registrales: T 36843 , F 178, S 8, H B 288554, I/A 5 (27.09.12).
- Revocaciones
ADM.UNICO: TARRES COSTA ELOI.
- Nombramientos
ADM.UNICO: ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL. REPR.143 RRM: MORA SAGUES BONAVENTURA.
- Otros Conceptos
PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD.
- Cambio de domicilio social
CL MUNTANER 185 PRINCIPAL (BARCELONA).
22/06/2011 Detalles del anuncio (181383)
- Depósitos de cuentas anuales
(Mayo de 2011) Año: 2009
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 16
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
---|---|---|---|
BORME-A-2015-62-08 | 01/04/2015 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2015-62-08 | 01/04/2015 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2015-37-08 | 24/02/2015 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-167-08 | 03/09/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-66-08 | 04/04/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-21-08 | 31/01/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2013-70-08 | 15/04/2013 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2012-202-08 | 19/10/2012 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2012-195-08 | 09/10/2012 | Barcelona | Descargar |
BORME-B-2011-119-08 | 22/06/2011 | Barcelona | Descargar |