TOTES ISOTONER ESPAÑA SL

Activa

AVENIDA EUROPA, 27 - BL 1 B PLT 1 2
Madrid  (28023)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 17/12/2024

ELKOUBY GEORGES

Consejero
Cese: 17/12/2024

ELKOUBY GEORGES

Presidente
Cese: 17/12/2024

ELKOUBY GEORGES

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 17/12/2024

HAMM DIDIER

Consejero
Nombramiento: 17/12/2024

HAMM DIDIER

Presidente
Nombramiento: 17/12/2024

HAMM DIDIER

Consejero delegado solidario
Cese: 07/11/2023

VAQUERO GARCIA FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 07/11/2023

REMANDET NADEGE CHRISTELLE

Apoderado
Cese: 29/11/2021

GARCIA PEON ALBERTO JOSE

Apoderado
Nombramiento: 21/12/2020

VAQUERO GARCIA FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 09/02/2018

GARCIA PEON ALBERTO JOSE

Apoderado
Cese: 02/10/2015

FARHI JACQUES

Presidente
Cese: 02/10/2015

FARHI JACQUES

Consejero
Cese: 02/10/2015

FARHI JACQUES

Consejero delegado
Nombramiento: 02/10/2015

ROBERT CORINNE

Consejero
Nombramiento: 02/10/2015

ELKOUBY GEORGES

Presidente
Nombramiento: 02/10/2015

ELKOUBY GEORGES

Consejero delegado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por TOTES ISOTONER ESPAÑA SL

17/12/2024 Detalles del anuncio (546377) Datos registrales: S 8 , H M 276151, I/A 11 (10.12.24).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ELKOUBY GEORGES. Presidente: ELKOUBY GEORGES. Cons.Del.Sol: ELKOUBY GEORGES.

  • Nombramientos

    Consejero: HAMM DIDIER. Presidente: HAMM DIDIER. Cons.Del.Sol: HAMM DIDIER.

07/11/2023 Detalles del anuncio (473153) Datos registrales: T 16268 , F 200, S 8, H M 276151, I/A 10 (30.10.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: VAQUERO GARCIA FRANCISCO JAVIER.

  • Nombramientos

    Apoderado: REMANDET NADEGE CHRISTELLE.

29/11/2021 Detalles del anuncio (516579) Datos registrales: T 16268 , F 199, S 8, H M 276151, I/A 9 (22.11.21).

  • Revocaciones

    Apoderado: GARCIA PEON ALBERTO JOSE.

21/12/2020 Detalles del anuncio (451257) Datos registrales: T 16268 , F 198, S 8, H M 276151, I/A 8 (14.12.20).

  • Nombramientos

    Apoderado: VAQUERO GARCIA FRANCISCO JAVIER.

09/02/2018 Detalles del anuncio (66112) Datos registrales: T 16268 , F 197, S 8, H M 276151, I/A 7 ( 1.02.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: GARCIA PEON ALBERTO JOSE.

02/10/2015 Detalles del anuncio (398548) Datos registrales: T 16268 , F 196, S 8, H M 276151, I/A 6 (25.09.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: FARHI JACQUES. Consejero: FARHI JACQUES. Con.Delegado: FARHI JACQUES.

  • Nombramientos

    Consejero: ROBERT CORINNE. Presidente: ELKOUBY GEORGES. Cons.Del.Sol: ELKOUBY GEORGES.

  • Otros Conceptos

    EL CONSEJERO DON GEORGES ELKOUBY HA OBTENIDO EN ESPAÑA EL N.I.E.

05/04/2011 Detalles del anuncio (122386)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Marzo de 2011) Año: 2010

05/05/2010 Detalles del anuncio (175800)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Abril de 2010) Año: 2009

20/03/2009 Detalles del anuncio (96929)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Marzo de 2009) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-242-28 17/12/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2023-212-28 07/11/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2021-228-28 29/11/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-243-28 21/12/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2018-29-28 09/02/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2015-189-28 02/10/2015 Madrid Descargar
BORME-B-2011-66-28 05/04/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-84-28 05/05/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-54-28 20/03/2009 Madrid Descargar