TORRE DE MIGUEL SOLAR SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
Fecha
|
Nombre
|
|
---|---|---|
Cese: 12/12/2014 | JIMENEZ SERRANO RAMON |
Representante |
Nombramiento: 12/12/2014 | REIN ROJO LUIS |
Representante |
Cese: 02/07/2013 | COBRA SISTEMAS Y REDES SA |
Administrador mancomunado |
Cese: 02/07/2013 | COBRA CONCESIONES SL |
Administrador mancomunado |
Cese: 02/07/2013 | DIAZ GONZALEZ RICARDO |
Administrador mancomunado |
Cese: 02/07/2013 | PALACIOS CASTAÑEDA LUIS |
Administrador mancomunado |
Cese: 02/07/2013 | JIMENEZ SERRANO RAMON |
Representante |
Cese: 02/07/2013 | MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS |
Representante |
Nombramiento: 02/07/2013 | COBRA SISTEMAS Y REDES SA |
Administrador único |
Nombramiento: 02/07/2013 | JIMENEZ SERRANO RAMON |
Representante |
Nombramiento: 11/12/2012 | YUNTA TOLEDO OSCAR MANUEL |
Apoderado |
Cese: 17/10/2012 | GOMEZ ZAMORA ANTONIO |
Representante |
Nombramiento: 17/10/2012 | MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS |
Representante |
Cese: 08/02/2012 | COBRA SISTEMAS Y REDES SA |
Administrador único |
Cese: 08/02/2012 | GOMEZ ZAMORA ANTONIO |
Representante |
Nombramiento: 08/02/2012 | GOMEZ ZAMORA ANTONIO |
Representante |
Nombramiento: 08/02/2012 | JIMENEZ SERRANO RAMON |
Representante |
Nombramiento: 08/02/2012 | COBRA SISTEMAS Y REDES SA |
Administrador mancomunado |
Nombramiento: 08/02/2012 | COBRA CONCESIONES SL |
Administrador mancomunado |
Nombramiento: 08/02/2012 | DIAZ GONZALEZ RICARDO |
Administrador mancomunado |
Nombramiento: 08/02/2012 | PALACIOS CASTAÑEDA LUIS |
Administrador mancomunado |
Cese: 24/01/2012 | MUÑOZ GONZALEZ ALBO JUAN MANUEL |
Apoderado |
Cese: 24/01/2012 | GOMEZ ZAMORA ANTONIO |
Apoderado |
Cese: 24/01/2012 | PEREZ LORENZO JAVIER |
Apoderado |
Cese: 24/01/2012 | GOMEZ ZAMORA ANTONIO |
Apoderado |
Cese: 21/12/2010 | LLORENTE GOMEZ EUGENIO BARTOLOME |
Representante |
Nombramiento: 21/12/2010 | GOMEZ ZAMORA ANTONIO |
Representante |
Nombramiento: 18/06/2009 | GOMEZ ZAMORA ANTONIO |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por TORRE DE MIGUEL SOLAR SL
16/03/2022 Detalles del anuncio (116713) Datos registrales: T 7043 , F 141, S 8, H SE130174, I/A 2 ( 7.03.22).
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.
COAGENER SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES SOCIEDAD D.
10/11/2016 Detalles del anuncio (450135) Datos registrales: T 28068 , F 128, S 8, H M 432985, I/A 14 (24.10.16).
- Disolución
Fusion.
- Extinción
12/12/2014 Detalles del anuncio (507491) Datos registrales: T 28068 , F 128, S 8, H M 432985, I/A 13 ( 2.12.14).
- Ceses/Dimisiones
Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON.
- Nombramientos
Representan: REIN ROJO LUIS.
02/07/2013 Detalles del anuncio (300868) Datos registrales: T 28068 , F 127, S 8, H M 432985, I/A 12 (24.06.13).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Mancom.: COBRA SISTEMAS Y REDES SA;COBRA CONCESIONES SL;DIAZ GONZALEZ RICARDO;PALACIOS CASTAÑEDA LUIS. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON;MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS.
- Nombramientos
Adm. Unico: COBRA SISTEMAS Y REDES SA. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON.
- Modificaciones Estatutarias
SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 12, 13, 22, 23, 24 Y 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; Y LOS ARTICULOS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 PASAN A TENER LA NUMERACION 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Y 37.-.Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único.
11/12/2012 Detalles del anuncio (511968) Datos registrales: T 28068 , F 126, S 8, H M 432985, I/A 11 (29.11.12).
- Nombramientos
Apoderado: YUNTA TOLEDO OSCAR MANUEL.
17/10/2012 Detalles del anuncio (422155) Datos registrales: T 28068 , F 126, S 8, H M 432985, I/A 10 ( 4.10.12).
- Ceses/Dimisiones
Representan: GOMEZ ZAMORA ANTONIO.
- Nombramientos
Representan: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS.
02/03/2012 Detalles del anuncio (103645) Datos registrales: T 28068 , F 126, S 8, H M 432985, I/A 9 (21.02.12).
- Ampliación de Capital
Capital: 10,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.020,00 Euros.
08/02/2012 Detalles del anuncio (63288) Datos registrales: T 28068 , F 124, S 8, H M 432985, I/A 8 (27.01.12).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: COBRA SISTEMAS Y REDES SA. Representan: GOMEZ ZAMORA ANTONIO.
- Nombramientos
Representan: GOMEZ ZAMORA ANTONIO;JIMENEZ SERRANO RAMON. Adm. Mancom.: COBRA SISTEMAS Y REDES SA;COBRA CONCESIONES SL;DIAZ GONZALEZ RICARDO;PALACIOS CASTAÑEDA LUIS.
- Modificaciones Estatutarias
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados.Modificados los artículos 12, 13, 22, 23 y 24 de los estatutos sociales, anulado el artículo 27, y los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 pasan a tener la numeración 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, respectivamente..
24/01/2012 Detalles del anuncio (33403) Datos registrales: T 28068 , F 124, S 8, H M 432985, I/A 7 ( 9.01.12).
- Revocaciones
Apoderado: MUÑOZ GONZALEZ ALBO JUAN MANUEL;GOMEZ ZAMORA ANTONIO;PEREZ LORENZO JAVIER;GOMEZ ZAMORA ANTONIO.
14/06/2011 Detalles del anuncio (173615)
- Depósitos de cuentas anuales
(Mayo de 2011) Año: 2010
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 14
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
---|---|---|---|
BORME-A-2022-52-41 | 16/03/2022 | Sevilla | Descargar |
BORME-A-2016-214-28 | 10/11/2016 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2014-237-28 | 12/12/2014 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2013-123-28 | 02/07/2013 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2012-236-28 | 11/12/2012 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2012-200-28 | 17/10/2012 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2012-44-28 | 02/03/2012 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2012-27-28 | 08/02/2012 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2012-16-28 | 24/01/2012 | Madrid | Descargar |
BORME-B-2011-113-28 | 14/06/2011 | Madrid | Descargar |