TENFA SL

Situación Concursal

C/ ZURBANO, Nº 49, OFICINA 4 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 05/04/2023

DIRECTORES DE TRANSICION Y GESTION SL

Liquidador
Cese: 05/04/2023

ECHECOPAR FLOREZ FERNANDO

Representante
Cese: 12/09/2019

VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA

Presidente
Cese: 12/09/2019

DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF

Consejero
Cese: 12/09/2019

HARROLD ALAN HENRY

Consejero
Cese: 12/09/2019

VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA

Consejero
Cese: 12/09/2019

CANALS BRAGE GUILLERMO

Secretario no consejero
Nombramiento: 12/09/2019

DIRECTORES DE TRANSICION Y GESTION SL

Liquidador
Nombramiento: 12/09/2019

ECHECOPAR FLOREZ FERNANDO

Representante
Cese: 17/03/2016

SANCHEZ SERRANO JAVIER

Representante
Cese: 19/10/2015

CARMONA GARCIA MARIA JESUS

Vicesecretario no consejero
Cese: 19/10/2015

DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF

Presidente
Cese: 19/10/2015

DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 19/10/2015

VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA

Presidente
Nombramiento: 19/10/2015

DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF

Consejero
Nombramiento: 19/10/2015

HARROLD ALAN HENRY

Consejero
Nombramiento: 19/10/2015

VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA

Consejero
Nombramiento: 28/09/2015

SANCHEZ SERRANO JAVIER

Representante
Nombramiento: 26/11/2012

CANALS BRAGE GUILLERMO

Secretario no consejero
Nombramiento: 26/11/2012

CARMONA GARCIA MARIA JESUS

Vicesecretario no consejero
Cese: 16/11/2012

OLIVERA PEREZ-FRADE GONZALO

Secretario
Cese: 16/11/2012

ARTES CASELLES ALBERTO

Vicesecretario no consejero
Cese: 26/06/2012

DE HOHENLOHE PABLO

Consejero
Cese: 26/06/2012

DE HOHENLOHE PABLO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 26/10/2011

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Nombramiento: 11/10/2010

ERNST & YOUNG SL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por TENFA SL

05/04/2023 Detalles del anuncio (165894) Datos registrales: T 30295 , F 212, S 8, H M 291387, I/A 32 (29.03.23).

  • Ceses/Dimisiones

    Liquidador: DIRECTORES DE TRANSICION Y GESTION SL. Representan: ECHECOPAR FLOREZ FERNANDO.

28/12/2020 Detalles del anuncio (462265) Datos registrales: T 30295 , F 212, S 8, H M 291387, I/A B (18.12.20).

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: No, Fecha de resolución 23/11/2020. Auto de declaración de cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID. Juez: JORGE MONTULL URQUIJO. Resoluciones: DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO.

12/09/2019 Detalles del anuncio (389673) Datos registrales: T 30295 , F 211, S 8, H M 291387, I/A 31 ( 5.09.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Presidente: VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA. Consejero: DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF;HARROLD ALAN HENRY;VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA. SecreNoConsj: CANALS BRAGE GUILLERMO.

  • Nombramientos

    Liquidador: DIRECTORES DE TRANSICION Y GESTION SL. Representan: ECHECOPAR FLOREZ FERNANDO.

  • Disolución

    Voluntaria.

17/03/2016 Detalles del anuncio (124785) Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 30 ( 9.03.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: SANCHEZ SERRANO JAVIER.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 12/11/2015. Sentencia de aprobación del convenio. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones: APROBAR EL CONVENIO ACEPTADO POR LA JUNTA DE ACREEDORES DE LA CONCURSADA, EL CUAL ADQUIRIRA PLENA EFICACIA DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCION JUDICIAL Y DESDE LA EFICACIA DEL CONVENIO CESARAN TODOS LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE CONCURSO Y LA ADMINISTRACION CONCURSAL.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 450/2012. Fecha de resolución 23/10/2012. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Administrador Concursal. Fecha 12/11/2015, NIF/CIF B86326386. GESTION CONCURSAL INTEGRAL SLP.

19/10/2015 Detalles del anuncio (417961) Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 29 ( 8.10.15).

  • Ceses/Dimisiones

    VsecrNoConsj: CARMONA GARCIA MARIA JESUS. Presidente: DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF. Cons.Del.Sol: DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF.

  • Nombramientos

    Presidente: VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA.

  • Reelecciones

    Consejero: DE HOHENLOHE HUBERTUS RUDOLF;HARROLD ALAN HENRY;VILALLONGA VON HOHENLOHE LANGENBURG FLAVIA IGNACIA.

28/09/2015 Detalles del anuncio (390543) Datos registrales: T 30295 , F 208, S 8, H M 291387, I/A A (21.09.15).

  • Nombramientos

    Representan: SANCHEZ SERRANO JAVIER.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: No, Fecha de resolución 23/10/2012. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones: SE DECLARA EN CONCURSO, QUE TIENE CARACTER DE VOLUNTARIO AL DEUDOR TENFA SL.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 450/2012. Fecha de resolución 23/10/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Administrador Concursal. Fecha 23/10/2012, NIF/CIF B86326386. GESTION CONCURSAL INTEGRAL SLP.

  • Situación Concursal

    Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: No, Fecha de resolución 23/10/2012. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones: EL DEUDOR TENFA SL CONSERVARA LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO DE ESTAS A LA INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES, MEDIANTE SU AUTORIZACION O CONFORMIDAD.

26/11/2012 Detalles del anuncio (485854) Datos registrales: T 17030 , F 102, S 8, H M 291387, I/A 28 (14.11.12).

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: CANALS BRAGE GUILLERMO. VsecrNoConsj: CARMONA GARCIA MARIA JESUS.

  • Cambio de domicilio social

    C/ ZURBANO, Nº 49, OFICINA 4 (MADRID).

16/11/2012 Detalles del anuncio (470082) Datos registrales: T 17030 , F 102, S 8, H M 291387, I/A 27 ( 5.11.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: OLIVERA PEREZ-FRADE GONZALO. VsecrNoConsj: ARTES CASELLES ALBERTO.

26/06/2012 Detalles del anuncio (269221) Datos registrales: T 17030 , F 102, S 8, H M 291387, I/A 26 (14.06.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DE HOHENLOHE PABLO. Cons.Del.Sol: DE HOHENLOHE PABLO.

26/10/2011 Detalles del anuncio (424278) Datos registrales: T 17030 , F 101, S 8, H M 291387, I/A 25 (14.10.11).

  • Reelecciones

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2023-66-28 05/04/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2020-247-28 28/12/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-175-28 12/09/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2016-53-28 17/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-199-28 19/10/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-185-28 28/09/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2012-226-28 26/11/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-220-28 16/11/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-120-28 26/06/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-204-28 26/10/2011 Madrid Descargar