SUIP INFONEGOCIO SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|  
							 Fecha 
						 | 
						 
							 Nombre 
						 | 
						|
|---|---|---|
| Cese: 22/12/2022 | SONNEDIX ZETA SL | 
						Administrador único | 
| Cese: 22/12/2022 | GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL | 
						Representante | 
| Nombramiento: 22/12/2022 | SONNEDIX ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA | 
						Administrador único | 
| Nombramiento: 22/12/2022 | GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL | 
						Representante | 
| Nombramiento: 06/05/2021 | FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL | 
						Apoderado | 
| Nombramiento: 06/05/2021 | GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE | 
						Apoderado | 
| Nombramiento: 04/05/2021 | FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL | 
						Apoderado | 
| Nombramiento: 04/05/2021 | GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE | 
						Apoderado | 
| Cese: 05/04/2021 | NORMANN MARC | 
						Administrador único | 
| Nombramiento: 05/04/2021 | SONNEDIX ZETA SL | 
						Administrador único | 
| Nombramiento: 05/04/2021 | GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL | 
						Representante | 
| Cese: 26/06/2020 | GANDIA FORNES JOSE LUIS | 
						Apoderado mancomunado | 
| Cese: 26/06/2020 | GANDIA FORNES JOSE LUIS | 
						Apoderado solidario | 
| Cese: 26/06/2020 | VILLALBA CORTES JUAN PABLO | 
						Apoderado mancomunado | 
| Cese: 26/06/2020 | VILLALBA CORTES JUAN PABLO | 
						Apoderado solidario | 
| Cese: 22/05/2020 | GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN | 
						Administrador único | 
| Nombramiento: 22/05/2020 | NORMANN MARC | 
						Administrador único | 
| Cese: 07/09/2018 | WICKE RICHARD | 
						Apoderado mancomunado | 
| Cese: 07/09/2018 | KARTES TILLMANN | 
						Apoderado solidario | 
| Nombramiento: 23/02/2017 | VILLALBA CORTES JUAN PABLO | 
						Apoderado mancomunado | 
| Nombramiento: 23/02/2017 | VILLALBA CORTES JUAN PABLO | 
						Apoderado solidario | 
| Nombramiento: 23/02/2017 | WICKE RICHARD | 
						Apoderado mancomunado | 
| Nombramiento: 23/02/2017 | GANDIA FORNES JOSE LUIS | 
						Apoderado mancomunado | 
| Cese: 23/02/2017 | FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA | 
						Apoderado solidario | 
| Cese: 28/06/2016 | LIEBEL CHRISTIAN | 
						Administrador solidario | 
| Cese: 28/06/2016 | GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN | 
						Administrador solidario | 
| Nombramiento: 28/06/2016 | GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN | 
						Administrador único | 
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SUIP INFONEGOCIO SL
30/01/2023 Detalles del anuncio (49105) Datos registrales: T 41353 , F 48, S 8, H M 732981, I/A 7 (23.01.23).
- Disolución
Fusion.
 - Extinción
 
22/12/2022 Detalles del anuncio (560469) Datos registrales: T 41353 , F 48, S 8, H M 732981, I/A 6 (15.12.22).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.
 - Nombramientos
Adm. Unico: SONNEDIX ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.
 
18/11/2021 Detalles del anuncio (502448) Datos registrales: T 41353 , F 47, S 8, H M 732981, I/A 5 (11.11.21).
- Sociedad Unipersonal
SONNEDIX OMICRON SL.
 
06/05/2021 Detalles del anuncio (208601) Datos registrales: T 41353 , F 47, S 8, H M 732981, I/A 4 (28.04.21).
- Nombramientos
Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE.
 
04/05/2021 Detalles del anuncio (202354) Datos registrales: T 41353 , F 46, S 8, H M 732981, I/A 3 (26.04.21).
- Nombramientos
Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE.
 
05/04/2021 Detalles del anuncio (152852) Datos registrales: T 41353 , F 46, S 8, H M 732981, I/A 2 (25.03.21).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: NORMANN MARC.
 - Nombramientos
Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.
 - Cambio de domicilio social
C/ PRINCIPE DE VERGARA, NUMERO 108, PLANTA 12 (MADRID).
 
26/06/2020 Detalles del anuncio (196701) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 5 (18.06.20).
- Revocaciones
Apo.Manc.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Apo.Manc.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO.
 
22/05/2020 Detalles del anuncio (162095) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 4 (13.05.20).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN.
 - Nombramientos
Adm. Unico: NORMANN MARC.
 
07/09/2018 Detalles del anuncio (368275) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 3 (31.08.18).
- Revocaciones
Apo.Manc.: WICKE RICHARD. Apo.Sol.: KARTES TILLMANN.
 
19/12/2017 Detalles del anuncio (495450) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 2 (12.12.17).
- Cambio de domicilio social
PLAZA ALQUERIA DE LA CULLA 4 - OFICINA 305 (ALFAFAR).
 
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18
| 
						 #CVE  
					 | 
					 
						 Fecha 
					 | 
					 
						 Provincia 
					 | 
					|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2023-20-28 | 30/01/2023 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2022-242-28 | 22/12/2022 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2021-221-28 | 18/11/2021 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2021-84-28 | 06/05/2021 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2021-82-28 | 04/05/2021 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2021-62-28 | 05/04/2021 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2020-122-46 | 26/06/2020 | Valencia/València | Descargar | 
| BORME-A-2020-97-46 | 22/05/2020 | Valencia/València | Descargar | 
| BORME-A-2018-173-46 | 07/09/2018 | Valencia/València | Descargar | 
| BORME-A-2017-239-46 | 19/12/2017 | Valencia/València | Descargar |