SUIP INFONEGOCIO SL

Extinta

C/ PRINCIPE DE VERGARA, NUMERO 108, PLANTA 12 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 22/12/2022

SONNEDIX ZETA SL

Administrador único
Cese: 22/12/2022

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Nombramiento: 22/12/2022

SONNEDIX ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA

Administrador único
Nombramiento: 22/12/2022

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Nombramiento: 06/05/2021

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 06/05/2021

GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2021

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2021

GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE

Apoderado
Cese: 05/04/2021

NORMANN MARC

Administrador único
Nombramiento: 05/04/2021

SONNEDIX ZETA SL

Administrador único
Nombramiento: 05/04/2021

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Cese: 26/06/2020

GANDIA FORNES JOSE LUIS

Apoderado mancomunado
Cese: 26/06/2020

GANDIA FORNES JOSE LUIS

Apoderado solidario
Cese: 26/06/2020

VILLALBA CORTES JUAN PABLO

Apoderado mancomunado
Cese: 26/06/2020

VILLALBA CORTES JUAN PABLO

Apoderado solidario
Cese: 22/05/2020

GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN

Administrador único
Nombramiento: 22/05/2020

NORMANN MARC

Administrador único
Cese: 07/09/2018

WICKE RICHARD

Apoderado mancomunado
Cese: 07/09/2018

KARTES TILLMANN

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/02/2017

VILLALBA CORTES JUAN PABLO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 23/02/2017

VILLALBA CORTES JUAN PABLO

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/02/2017

WICKE RICHARD

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 23/02/2017

GANDIA FORNES JOSE LUIS

Apoderado mancomunado
Cese: 23/02/2017

FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA

Apoderado solidario
Cese: 28/06/2016

LIEBEL CHRISTIAN

Administrador solidario
Cese: 28/06/2016

GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN

Administrador solidario
Nombramiento: 28/06/2016

GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SUIP INFONEGOCIO SL

30/01/2023 Detalles del anuncio (49105) Datos registrales: T 41353 , F 48, S 8, H M 732981, I/A 7 (23.01.23).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

22/12/2022 Detalles del anuncio (560469) Datos registrales: T 41353 , F 48, S 8, H M 732981, I/A 6 (15.12.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SONNEDIX ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

18/11/2021 Detalles del anuncio (502448) Datos registrales: T 41353 , F 47, S 8, H M 732981, I/A 5 (11.11.21).

  • Sociedad Unipersonal

    SONNEDIX OMICRON SL.

06/05/2021 Detalles del anuncio (208601) Datos registrales: T 41353 , F 47, S 8, H M 732981, I/A 4 (28.04.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE.

04/05/2021 Detalles del anuncio (202354) Datos registrales: T 41353 , F 46, S 8, H M 732981, I/A 3 (26.04.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE.

05/04/2021 Detalles del anuncio (152852) Datos registrales: T 41353 , F 46, S 8, H M 732981, I/A 2 (25.03.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: NORMANN MARC.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

  • Cambio de domicilio social

    C/ PRINCIPE DE VERGARA, NUMERO 108, PLANTA 12 (MADRID).

26/06/2020 Detalles del anuncio (196701) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 5 (18.06.20).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Apo.Manc.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO.

22/05/2020 Detalles del anuncio (162095) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 4 (13.05.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: NORMANN MARC.

07/09/2018 Detalles del anuncio (368275) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 3 (31.08.18).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: WICKE RICHARD. Apo.Sol.: KARTES TILLMANN.

19/12/2017 Detalles del anuncio (495450) Datos registrales: T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 2 (12.12.17).

  • Cambio de domicilio social

    PLAZA ALQUERIA DE LA CULLA 4 - OFICINA 305 (ALFAFAR).

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2023-20-28 30/01/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-242-28 22/12/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-221-28 18/11/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-84-28 06/05/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-82-28 04/05/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-62-28 05/04/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-122-46 26/06/2020 Valencia/València Descargar
BORME-A-2020-97-46 22/05/2020 Valencia/València Descargar
BORME-A-2018-173-46 07/09/2018 Valencia/València Descargar
BORME-A-2017-239-46 19/12/2017 Valencia/València Descargar