SOLVENTIS AV SA

Cambio de denominación social

PASEO DE LA CASTELLANA 60 4 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 24/05/2022

MORO MARTINEZ ALBERTO

Apoderado
Cese: 24/05/2022

MORO RODRIGUEZ VICTOR

Consejero
Cese: 24/05/2022

MORO RODRIGUEZ VICTOR

Presidente
Cese: 24/05/2022

MORO SUAREZ ALBERTO

Consejero delegado
Nombramiento: 24/05/2022

MORO SUAREZ ALBERTO

Presidente
Cese: 11/10/2021

MASDEVALL GARCON CARLOS

Apoderado mancomunado
Cese: 11/10/2021

ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO

Apoderado mancomunado
Cese: 11/10/2021

MORO SUAREZ PABLO DANIEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 11/10/2021

ALFARO BAU GUILLERMO

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2021

MASDEVALL GARCON CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2021

MORO SUAREZ PABLO DANIEL

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2021

TORRES LANG CHRISTIAN

Apoderado
Cese: 07/05/2021

VL FINANCIAL OFFICE SL

Apoderado
Nombramiento: 27/07/2020

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 18/11/2019

ARNOULT TORRA-BALARI CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 18/11/2019

GALSTOCK INVESTMENT SL

Apoderado
Nombramiento: 22/10/2019

MASDEVALL GARCON CARLOS

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 22/10/2019

ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 22/10/2019

MORO SUAREZ PABLO DANIEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 05/09/2019

MORO SUAREZ ALBERTO

Consejero delegado
Cese: 25/07/2019

MORO SUAREZ ALBERTO

Consejero delegado
Nombramiento: 25/07/2019

ALFARO BAU GUILLERMO

Consejero
Nombramiento: 25/07/2019

BAU JOVER JOSE

Consejero
Nombramiento: 25/07/2019

MORO RODRIGUEZ VICTOR

Consejero
Nombramiento: 25/07/2019

MORO SUAREZ ALBERTO

Consejero
Cese: 11/04/2019

ACP ASESORES GENERALES SL

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SOLVENTIS AV SA

28/09/2022 Detalles del anuncio (430258) Datos registrales: T 36673 , F 114, S 8, H M 657519, I/A 23 (21.09.22).

  • Cambio de denominación social

    SOLVENTIS SV SA.

  • Cambio de objeto social

    A.- Servicios y Actividades de Inversión. La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros. La ejecución de órdenes por cuenta de clientes. La negociación por cuenta propia. Etc.

24/05/2022 Detalles del anuncio (233912) Datos registrales: T 36673 , F 113, S 8, H M 657519, I/A 22 (17.05.22).

  • Nombramientos

    Apoderado: MORO MARTINEZ ALBERTO.

24/05/2022 Detalles del anuncio (233911) Datos registrales: T 36673 , F 112, S 8, H M 657519, I/A 21 (17.05.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MORO RODRIGUEZ VICTOR. Presidente: MORO RODRIGUEZ VICTOR. Con.Delegado: MORO SUAREZ ALBERTO.

  • Nombramientos

    Presidente: MORO SUAREZ ALBERTO.

11/10/2021 Detalles del anuncio (448619) Datos registrales: T 36673 , F 111, S 8, H M 657519, I/A 19 ( 4.10.21).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: MASDEVALL GARCON CARLOS;ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO;MORO SUAREZ PABLO DANIEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: ALFARO BAU GUILLERMO;MASDEVALL GARCON CARLOS;MORO SUAREZ PABLO DANIEL;TORRES LANG CHRISTIAN.

07/05/2021 Detalles del anuncio (212107) Datos registrales: T 36673 , F 111, S 8, H M 657519, I/A 18 (29.04.21).

  • Revocaciones

    Apoderado: VL FINANCIAL OFFICE SL.

27/07/2020 Detalles del anuncio (242206) Datos registrales: T 36673 , F 111, S 8, H M 657519, I/A 17 (20.07.20).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

18/11/2019 Detalles del anuncio (475856) Datos registrales: T 36673 , F 110, S 8, H M 657519, I/A 16 (11.11.19).

  • Nombramientos

    Apoderado: ARNOULT TORRA-BALARI CARLOS.

  • Nombramientos

    Apoderado: GALSTOCK INVESTMENT SL.

22/10/2019 Detalles del anuncio (437365) Datos registrales: T 36673 , F 110, S 8, H M 657519, I/A 14 (15.10.19).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: MASDEVALL GARCON CARLOS;ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO;MORO SUAREZ PABLO DANIEL.

  • Otros Conceptos

    Revocados los PODERES MANCOMUNADOS conferidos a favor de D. Carlos Masdevall Garçon, D. Christian José Torres Lang, D. Guillermo Alejandro Alfaro Bau, D. Pablo Daniel Moro Suárez y de D. Pedro Arranz Martín. en virtud de escritura que causó la inscripción 4ª de la hoja registral.

05/09/2019 Detalles del anuncio (381694) Datos registrales: T 36673 , F 109, S 8, H M 657519, I/A 13 (29.08.19).

  • Nombramientos

    Con.Delegado: MORO SUAREZ ALBERTO.

25/07/2019 Detalles del anuncio (324271) Datos registrales: T 36673 , F 109, S 8, H M 657519, I/A 12 (18.07.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Con.Delegado: MORO SUAREZ ALBERTO.

  • Reelecciones

    Consejero: ALFARO BAU GUILLERMO;BAU JOVER JOSE;MORO RODRIGUEZ VICTOR;MORO SUAREZ ALBERTO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 41

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-186-28 28/09/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-97-28 24/05/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-97-28 24/05/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-196-28 11/10/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-85-28 07/05/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-143-28 27/07/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-221-28 18/11/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-203-28 22/10/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-170-28 05/09/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-141-28 25/07/2019 Madrid Descargar