SOLVENTIS AV SA
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 24/05/2022 | MORO MARTINEZ ALBERTO |
Apoderado |
| Cese: 24/05/2022 | MORO RODRIGUEZ VICTOR |
Consejero |
| Cese: 24/05/2022 | MORO RODRIGUEZ VICTOR |
Presidente |
| Cese: 24/05/2022 | MORO SUAREZ ALBERTO |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 24/05/2022 | MORO SUAREZ ALBERTO |
Presidente |
| Cese: 11/10/2021 | MASDEVALL GARCON CARLOS |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 11/10/2021 | ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 11/10/2021 | MORO SUAREZ PABLO DANIEL |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 11/10/2021 | ALFARO BAU GUILLERMO |
Apoderado |
| Nombramiento: 11/10/2021 | MASDEVALL GARCON CARLOS |
Apoderado |
| Nombramiento: 11/10/2021 | MORO SUAREZ PABLO DANIEL |
Apoderado |
| Nombramiento: 11/10/2021 | TORRES LANG CHRISTIAN |
Apoderado |
| Cese: 07/05/2021 | VL FINANCIAL OFFICE SL |
Apoderado |
| Nombramiento: 27/07/2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
| Nombramiento: 18/11/2019 | ARNOULT TORRA-BALARI CARLOS |
Apoderado |
| Nombramiento: 18/11/2019 | GALSTOCK INVESTMENT SL |
Apoderado |
| Nombramiento: 22/10/2019 | MASDEVALL GARCON CARLOS |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 22/10/2019 | ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 22/10/2019 | MORO SUAREZ PABLO DANIEL |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 05/09/2019 | MORO SUAREZ ALBERTO |
Consejero delegado |
| Cese: 25/07/2019 | MORO SUAREZ ALBERTO |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 25/07/2019 | ALFARO BAU GUILLERMO |
Consejero |
| Nombramiento: 25/07/2019 | BAU JOVER JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 25/07/2019 | MORO RODRIGUEZ VICTOR |
Consejero |
| Nombramiento: 25/07/2019 | MORO SUAREZ ALBERTO |
Consejero |
| Cese: 11/04/2019 | ACP ASESORES GENERALES SL |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SOLVENTIS AV SA
28/09/2022 Detalles del anuncio (430258) Datos registrales: T 36673 , F 114, S 8, H M 657519, I/A 23 (21.09.22).
- Cambio de denominación social
SOLVENTIS SV SA.
- Cambio de objeto social
A.- Servicios y Actividades de Inversión. La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros. La ejecución de órdenes por cuenta de clientes. La negociación por cuenta propia. Etc.
24/05/2022 Detalles del anuncio (233912) Datos registrales: T 36673 , F 113, S 8, H M 657519, I/A 22 (17.05.22).
- Nombramientos
Apoderado: MORO MARTINEZ ALBERTO.
24/05/2022 Detalles del anuncio (233911) Datos registrales: T 36673 , F 112, S 8, H M 657519, I/A 21 (17.05.22).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: MORO RODRIGUEZ VICTOR. Presidente: MORO RODRIGUEZ VICTOR. Con.Delegado: MORO SUAREZ ALBERTO.
- Nombramientos
Presidente: MORO SUAREZ ALBERTO.
11/10/2021 Detalles del anuncio (448619) Datos registrales: T 36673 , F 111, S 8, H M 657519, I/A 19 ( 4.10.21).
- Revocaciones
Apo.Manc.: MASDEVALL GARCON CARLOS;ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO;MORO SUAREZ PABLO DANIEL.
- Nombramientos
Apoderado: ALFARO BAU GUILLERMO;MASDEVALL GARCON CARLOS;MORO SUAREZ PABLO DANIEL;TORRES LANG CHRISTIAN.
07/05/2021 Detalles del anuncio (212107) Datos registrales: T 36673 , F 111, S 8, H M 657519, I/A 18 (29.04.21).
- Revocaciones
Apoderado: VL FINANCIAL OFFICE SL.
27/07/2020 Detalles del anuncio (242206) Datos registrales: T 36673 , F 111, S 8, H M 657519, I/A 17 (20.07.20).
- Reelecciones
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
18/11/2019 Detalles del anuncio (475856) Datos registrales: T 36673 , F 110, S 8, H M 657519, I/A 16 (11.11.19).
- Nombramientos
Apoderado: ARNOULT TORRA-BALARI CARLOS.
- Nombramientos
Apoderado: GALSTOCK INVESTMENT SL.
22/10/2019 Detalles del anuncio (437365) Datos registrales: T 36673 , F 110, S 8, H M 657519, I/A 14 (15.10.19).
- Nombramientos
Apo.Manc.: MASDEVALL GARCON CARLOS;ALFARO BAU GUILLERMO ALEJANDRO;MORO SUAREZ PABLO DANIEL.
- Otros Conceptos
Revocados los PODERES MANCOMUNADOS conferidos a favor de D. Carlos Masdevall Garçon, D. Christian José Torres Lang, D. Guillermo Alejandro Alfaro Bau, D. Pablo Daniel Moro Suárez y de D. Pedro Arranz Martín. en virtud de escritura que causó la inscripción 4ª de la hoja registral.
05/09/2019 Detalles del anuncio (381694) Datos registrales: T 36673 , F 109, S 8, H M 657519, I/A 13 (29.08.19).
- Nombramientos
Con.Delegado: MORO SUAREZ ALBERTO.
25/07/2019 Detalles del anuncio (324271) Datos registrales: T 36673 , F 109, S 8, H M 657519, I/A 12 (18.07.19).
- Ceses/Dimisiones
Con.Delegado: MORO SUAREZ ALBERTO.
- Reelecciones
Consejero: ALFARO BAU GUILLERMO;BAU JOVER JOSE;MORO RODRIGUEZ VICTOR;MORO SUAREZ ALBERTO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 41
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-186-28 | 28/09/2022 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2022-97-28 | 24/05/2022 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2022-97-28 | 24/05/2022 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2021-196-28 | 11/10/2021 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2021-85-28 | 07/05/2021 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2020-143-28 | 27/07/2020 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-221-28 | 18/11/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-203-28 | 22/10/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-170-28 | 05/09/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-141-28 | 25/07/2019 | Madrid | Descargar |