SOFRIMO IBERIA SL

Extinta

C/ PRIM 19 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 11/12/2019

DELON SERGE

Administrador solidario
Cese: 11/12/2019

CHAUVEL PIERRE

Administrador solidario
Nombramiento: 11/12/2019

VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SL

Liquidador
Nombramiento: 11/12/2019

REYES SOSA DANIELA SALIME

Representante
Cese: 31/10/2018

OLIVER DE QUEROL MARIA VICTORIA

Apoderado
Nombramiento: 31/10/2018

VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SL

Apoderado
Cese: 21/06/2018

GIAOUI NORBERT

Consejero
Cese: 21/06/2018

GIAOUI NORBERT

Presidente
Cese: 21/06/2018

GIAOUI NORBERT

Consejero delegado
Cese: 21/06/2018

DELON SERGE

Consejero
Cese: 21/06/2018

CHAUVEL PIERRE

Consejero
Nombramiento: 21/06/2018

DELON SERGE

Administrador solidario
Nombramiento: 21/06/2018

CHAUVEL PIERRE

Administrador solidario
Cese: 25/05/2016

REVIRIEGO COLL JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 25/05/2016

OLIVER DE QUEROL MARIA VICTORIA

Apoderado
Nombramiento: 25/05/2016

VISTRA ADMINISTRACION SERVICES SLU

Apoderado
Cese: 25/05/2016

REVIRIEGO COLL JOSE LUIS

Secretario no consejero
Nombramiento: 25/05/2016

OLIVER DE QUEROL MARIA VICTORIA

Secretario no consejero
Nombramiento: 13/04/2015

DELON SERGE MAURICE RENE

Apoderado
Cese: 25/04/2013

LANGLOIS DENIS

Consejero
Cese: 30/05/2012

RUSSO EDWARD

Consejero
Nombramiento: 30/05/2012

LANGLOIS DENIS

Consejero
Nombramiento: 30/05/2012

CHAUVEL PIERRE

Consejero
Nombramiento: 03/11/2011

RIBALTA NOGUERA CRISTINA

Apoderado
Nombramiento: 26/10/2011

REVIRIEGO COLL JOSE LUIS

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SOFRIMO IBERIA SL

11/12/2019 Detalles del anuncio (508204) Datos registrales: T 38163 , F 42, S 8, H M 518346, I/A 13 ( 2.12.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: DELON SERGE;CHAUVEL PIERRE.

  • Nombramientos

    Liquidador: VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SL. Representan: REYES SOSA DANIELA SALIME.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

    Depósito de libros.

31/10/2018 Detalles del anuncio (436197) Datos registrales: T 28788 , F 111, S 8, H M 518346, I/A 12 (23.10.18).

  • Revocaciones

    Apoderado: OLIVER DE QUEROL MARIA VICTORIA.

  • Nombramientos

    Apoderado: VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SL.

21/06/2018 Detalles del anuncio (261577) Datos registrales: T 28788 , F 111, S 8, H M 518346, I/A 11 (13.06.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GIAOUI NORBERT. Presidente: GIAOUI NORBERT. Con.Delegado: GIAOUI NORBERT. Consejero: DELON SERGE;CHAUVEL PIERRE.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: DELON SERGE;CHAUVEL PIERRE.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.

25/05/2016 Detalles del anuncio (222085) Datos registrales: T 28788 , F 110, S 8, H M 518346, I/A 10 (17.05.16).

  • Revocaciones

    Apoderado: REVIRIEGO COLL JOSE LUIS.

  • Nombramientos

    Apoderado: OLIVER DE QUEROL MARIA VICTORIA;VISTRA ADMINISTRACION SERVICES SLU.

25/05/2016 Detalles del anuncio (222084) Datos registrales: T 28788 , F 110, S 8, H M 518346, I/A 9 (17.05.16).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: REVIRIEGO COLL JOSE LUIS.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: OLIVER DE QUEROL MARIA VICTORIA.

13/04/2015 Detalles del anuncio (151543) Datos registrales: T 28788 , F 109, S 8, H M 518346, I/A 8 ( 1.04.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: DELON SERGE MAURICE RENE.

01/10/2014 Detalles del anuncio (390386) Datos registrales: T 28788 , F 109, S 8, H M 518346, I/A 7 (23.09.14).

  • Cambio de domicilio social

    C/ PRIM 19 (MADRID).

25/04/2013 Detalles del anuncio (195053) Datos registrales: T 28788 , F 109, S 8, H M 518346, I/A 6 (16.04.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LANGLOIS DENIS.

30/05/2012 Detalles del anuncio (229485) Datos registrales: T 28788 , F 108, S 8, H M 518346, I/A 5 (18.05.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: RUSSO EDWARD.

  • Nombramientos

    Consejero: LANGLOIS DENIS;CHAUVEL PIERRE.

03/11/2011 Detalles del anuncio (436152) Datos registrales: T 28788 , F 108, S 8, H M 518346, I/A 4 (20.10.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: RIBALTA NOGUERA CRISTINA.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 13

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2019-236-28 11/12/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-210-28 31/10/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-118-28 21/06/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2016-98-28 25/05/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-98-28 25/05/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-68-28 13/04/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-187-28 01/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-78-28 25/04/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-101-28 30/05/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-209-28 03/11/2011 Madrid Descargar