SETOR SA

Extinta

CALLE ARTURO SORIA, 29
Madrid  (28027)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 28/12/2018

PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO

Administrador solidario
Cese: 28/12/2018

SHEEHAN JUNKO IO

Administrador solidario
Cese: 28/12/2018

COLE BRIAN ROY

Administrador solidario
Cese: 28/12/2018

ONIEVA LLORD CRISTINA

Representante
Cese: 28/12/2018

ONIEVA HERRERO CARLOS

Representante
Cese: 28/12/2018

HERRERO DE LUCAS DANIEL

Representante
Nombramiento: 27/11/2018

AZNAR MORENO MARIA DEL MAR

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 27/11/2018

BARNUSELL CORONADO JORGE

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 27/11/2018

JIMENEZ DIEZMA ROSA MARIA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 28/06/2018

GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 28/06/2018

LOPEZ FERNANDEZ JULIA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 28/06/2018

BARNUSELL CORONADO JORGE

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 08/01/2018

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Cese: 21/12/2017

PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO

Administrador único
Nombramiento: 21/12/2017

PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO

Administrador solidario
Nombramiento: 21/12/2017

SHEEHAN JUNKO IO

Administrador solidario
Nombramiento: 21/12/2017

COLE BRIAN ROY

Administrador solidario
Cese: 27/11/2017

GARCIA NEBREDA VICTOR JOSE

Apoderado
Cese: 27/11/2017

ONIEVA HERRERO ANTONIO

Apoderado
Cese: 27/11/2017

JIMENEZ GONZALO GONZALO

Apoderado
Nombramiento: 27/11/2017

AZNAR MORENO MARIA DEL MAR

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 27/11/2017

ARAUZO ARRANZ JESUS JULIAN

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 27/11/2017

GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 27/11/2017

LOPEZ FERNANDEZ JULIA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 14/09/2017

PARTICIPASA SL

Consejero
Cese: 14/09/2017

ONYHER SL

Consejero
Cese: 14/09/2017

LHEDAT SL

Consejero
Cese: 14/09/2017

ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS

Consejero
Cese: 14/09/2017

ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS

Presidente
Cese: 14/09/2017

ONYHER SL

Secretario
Cese: 14/09/2017

ALBARRAN ISABEL JESUS

Consejero delegado solidario
Cese: 14/09/2017

ONYHER SL

Consejero delegado solidario
Cese: 14/09/2017

LHEDAT SL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 14/09/2017

PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO

Administrador único
Cese: 30/12/2016

ROT FERNANDEZ ANTONIO

Apoderado
Cese: 30/12/2016

ROT FERNANDEZ ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 19/12/2016

JIMENEZ GONZALO GONZALO

Apoderado
Nombramiento: 28/05/2015

ALBARRAN ISABEL JESUS

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 28/05/2015

ONYHER SL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 28/05/2015

LHEDAT SL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 28/05/2015

ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS

Presidente
Nombramiento: 28/05/2015

ONYHER SL

Secretario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SETOR SA

28/12/2018 Detalles del anuncio (522454) Datos registrales: T 36330 , F 144, S 8, H M 124751, I/A 62 (20.12.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY. Representan: ONIEVA LLORD CRISTINA;ONIEVA HERRERO CARLOS;HERRERO DE LUCAS DANIEL.

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

27/11/2018 Detalles del anuncio (473620) Datos registrales: T 36330 , F 143, S 8, H M 124751, I/A 61 (20.11.18).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: AZNAR MORENO MARIA DEL MAR;BARNUSELL CORONADO JORGE;JIMENEZ DIEZMA ROSA MARIA.

28/06/2018 Detalles del anuncio (272093) Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 60 (21.06.18).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA;BARNUSELL CORONADO JORGE.

08/01/2018 Detalles del anuncio (10088) Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 59 (29.12.17).

  • Nombramientos

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

21/12/2017 Detalles del anuncio (499920) Datos registrales: T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 58 (14.12.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY.

  • Modificaciones Estatutarias

    Modificado el artículo 10bis.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.

20/12/2017 Detalles del anuncio (496890) Datos registrales: T 36330 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 57 (11.12.17).

  • Ampliación del Objeto Social

    EL EJERCICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA OPERACION Y GESTION AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.

27/11/2017 Detalles del anuncio (464363) Datos registrales: T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 56 (14.11.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: GARCIA NEBREDA VICTOR JOSE;ONIEVA HERRERO ANTONIO;JIMENEZ GONZALO GONZALO.

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: AZNAR MORENO MARIA DEL MAR;ARAUZO ARRANZ JESUS JULIAN;GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA.

21/09/2017 Detalles del anuncio (378810) Datos registrales: T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 54 ( 7.09.17).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    ATEN OIL SETOR SL.

21/09/2017 Detalles del anuncio (378811) Datos registrales: T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 55 ( 7.09.17).

  • Ampliación del Objeto Social

    Articulo 4 .- Constituye el objeto de la sociedad la instalación y explotación de estaciones de servicio para el suministro de gasolina, carburantes y lubrificantes en general, tanto por concesión directa, como por arrendamiento o cualquier otro titulo. La instalación y explotación de comercios y t.

14/09/2017 Detalles del anuncio (370515) Datos registrales: T 28444 , F 140, S 8, H M 124751, I/A 53 ( 6.09.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: PARTICIPASA SL;ONYHER SL;LHEDAT SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Secretario: ONYHER SL. Cons.Del.Sol: ALBARRAN ISABEL JESUS;ONYHER SL;LHEDAT SL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: PORTEROS MAÑUECO LIBORIO ALVARO.

  • Modificaciones Estatutarias

    Creacion del articulo 10 bis en los estatutos sociales y modificacion del articulo 10 de los estatutos sociales. .

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 25

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2018-248-28 28/12/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-227-28 27/11/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-123-28 28/06/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-5-28 08/01/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-241-28 21/12/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-240-28 20/12/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-225-28 27/11/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-181-28 21/09/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-181-28 21/09/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-176-28 14/09/2017 Madrid Descargar