SARRIA PARC SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 18/11/2010 | BELLAFONT ALVARO LUIS |
Apoderado |
| Cese: 26/07/2010 | LLENA NICOLAU JUAN CARLOS |
Apoderado |
| Nombramiento: 12/07/2010 | CASAJUANA MIRAS ALBERT |
Apoderado |
| Cese: 08/03/2010 | CARBONELL TARRES JOSEP |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 08/03/2010 | CARBONELL MARCET BENITO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 20/11/2009 | MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL |
Apoderado |
| Nombramiento: 20/11/2009 | GALOPA VILARET JOSEP MARIA |
Apoderado |
| Cese: 05/10/2009 | PALOUZIE SARRAT JOSE FELIX |
Apoderado |
| Cese: 05/10/2009 | BAIGET CASTILLO JUAN |
Apoderado |
| Cese: 05/10/2009 | DOMINGUEZ TARANCON NURIA |
Apoderado |
| Cese: 25/06/2009 | HUGO PUGLISI |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SARRIA PARC SL
12/01/2011 Detalles del anuncio (10733) Datos registrales: T 41975 , F 103, S 8, H B 287662, I/A 26 (29.12.10).
- Extinción
22/12/2010 Detalles del anuncio (1169008)
- Depósitos de cuentas anuales
(Noviembre de 2010) Año: 2009
18/11/2010 Detalles del anuncio (424408) Datos registrales: T 41975 , F 103, S 8, H B 287662, I/A 25 ( 5.11.10).
- Revocaciones
APODERADO: BELLAFONT ALVARO LUIS.
26/07/2010 Detalles del anuncio (291941) Datos registrales: T 41975 , F 103, S 8, H B 287662, I/A 24 (15.07.10).
- Revocaciones
APODERADO: LLENA NICOLAU JUAN CARLOS.
12/07/2010 Detalles del anuncio (273620) Datos registrales: T 39056 , F 225, S 8, H B 287662, I/A 23 (30.06.10).
- Nombramientos
APODERADO: CASAJUANA MIRAS ALBERT.
08/03/2010 Detalles del anuncio (97031) Datos registrales: T 39056 , F 225, S 8, H B 287662, I/A 22 (24.02.10).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: CARBONELL TARRES JOSEP.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: CARBONELL MARCET BENITO.
20/11/2009 Detalles del anuncio (486014) Datos registrales: T 39056 , F 224, S 8, H B 287662, I/A 21 (10.11.09).
- Nombramientos
APODERADO: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;GALOPA VILARET JOSEP MARIA.
05/10/2009 Detalles del anuncio (417920) Datos registrales: T 39056 , F 223, S 8, H B 287662, I/A 20 (22.09.09).
- Revocaciones
APODERADO: PALOUZIE SARRAT JOSE FELIX;BAIGET CASTILLO JUAN;DOMINGUEZ TARANCON NURIA.
28/09/2009 Detalles del anuncio (528876)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2009) Año: 2008
25/06/2009 Detalles del anuncio (286935) Datos registrales: T 39056 , F 223, S 8, H B 287662, I/A 19 (15.06.09).
- Revocaciones
APODERADO: HUGO PUGLISI.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 10
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2011-7-08 | 12/01/2011 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2010-243-08 | 22/12/2010 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2010-221-08 | 18/11/2010 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2010-141-08 | 26/07/2010 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2010-131-08 | 12/07/2010 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2010-45-08 | 08/03/2010 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2009-222-08 | 20/11/2009 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2009-190-08 | 05/10/2009 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2009-185-08 | 28/09/2009 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2009-118-08 | 25/06/2009 | Barcelona | Descargar |