SACYR CONSTRUCCION APARCAMIENTOS DAOIZ Y VELARDE SL

Cambio de denominación social

C/ CONDESA DE VENADITO 7 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 26/12/2023

SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL

Administrador solidario
Cese: 26/12/2023

SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL

Administrador solidario
Cese: 26/12/2023

GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO

Representante
Cese: 26/12/2023

GARCIA GONZALEZ IGNACIO

Representante
Nombramiento: 26/12/2023

GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO

Representante
Nombramiento: 26/12/2023

VIADERO CANALES JESUS DAVID

Representante
Nombramiento: 26/12/2023

SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 26/12/2023

SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 11/10/2023

GOMEZ DEL RIO SANZ-HERNANZ RAFAEL

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2023

JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2023

PELLON REVUELTA LEOPOLDO JOSE

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2023

GARCIA GONZALEZ IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2023

RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO

Apoderado
Nombramiento: 11/10/2023

RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ

Apoderado
Cese: 10/10/2023

GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 10/10/2023

JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 16/08/2023

BDO AUDITORES SLP

Auditor
Cese: 28/06/2023

FERNANDEZ PEREZ MARIA

Apoderado
Cese: 28/06/2023

FERNANDEZ PEREZ MARIA

Apoderado solidario
Cese: 27/01/2023

PELLON REVUELTA LEOPOLDO

Representante
Nombramiento: 27/01/2023

GARCIA GONZALEZ IGNACIO

Representante
Cese: 20/01/2023

GUIO CALLEJA JAVIER

Representante
Nombramiento: 20/01/2023

GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO

Representante
Cese: 13/01/2023

TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL

Apoderado
Cese: 13/01/2023

TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 29/09/2022

SUERO MARCOS LOURDES

Apoderado solidario
Nombramiento: 20/06/2022

BDO AUDITORES SLP

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por SACYR CONSTRUCCION APARCAMIENTOS DAOIZ Y VELARDE SL

25/09/2024 Detalles del anuncio (410612) Datos registrales: S 8 , H M 631030, I/A 34 (18.09.24).

  • Cambio de denominación social

    APARCAMIENTO DAOIZ Y VELARDE SL.

26/12/2023 Detalles del anuncio (547236) Datos registrales: T 38537 , F 11, S 8, H M 631030, I/A 33 (18.12.23).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL. Representan: GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO;GARCIA GONZALEZ IGNACIO.

  • Nombramientos

    Representan: GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO;VIADERO CANALES JESUS DAVID. Adm. Mancom.: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados.

11/10/2023 Detalles del anuncio (435515) Datos registrales: T 38537 , F 8, S 8, H M 631030, I/A 32 ( 4.10.23).

  • Nombramientos

    Apoderado: GOMEZ DEL RIO SANZ-HERNANZ RAFAEL;JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO;PELLON REVUELTA LEOPOLDO JOSE;GARCIA GONZALEZ IGNACIO;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ.

10/10/2023 Detalles del anuncio (433289) Datos registrales: T 38537 , F 8, S 8, H M 631030, I/A 31 ( 3.10.23).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO.

16/08/2023 Detalles del anuncio (368401) Datos registrales: T 38537 , F 7, S 8, H M 631030, I/A 30 ( 8.08.23).

  • Reelecciones

    Auditor: BDO AUDITORES SLP.

28/06/2023 Detalles del anuncio (292752) Datos registrales: T 38537 , F 7, S 8, H M 631030, I/A 29 (21.06.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: FERNANDEZ PEREZ MARIA. Apo.Sol.: FERNANDEZ PEREZ MARIA.

27/01/2023 Detalles del anuncio (46874) Datos registrales: T 38537 , F 7, S 8, H M 631030, I/A 28 (20.01.23).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: PELLON REVUELTA LEOPOLDO.

  • Nombramientos

    Representan: GARCIA GONZALEZ IGNACIO.

20/01/2023 Detalles del anuncio (33270) Datos registrales: T 38537 , F 7, S 8, H M 631030, I/A 27 (13.01.23).

  • Ceses/Dimisiones

    Representan: GUIO CALLEJA JAVIER.

  • Nombramientos

    Representan: GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO.

13/01/2023 Detalles del anuncio (19657) Datos registrales: T 38537 , F 7, S 8, H M 631030, I/A 26 ( 5.01.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL. Apo.Sol.: TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL.

29/09/2022 Detalles del anuncio (432487) Datos registrales: T 38537 , F 6, S 8, H M 631030, I/A 25 (22.09.22).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: SUERO MARCOS LOURDES.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 34

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-185-28 25/09/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2023-243-28 26/12/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-195-28 11/10/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-194-28 10/10/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-155-28 16/08/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-121-28 28/06/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-19-28 27/01/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-14-28 20/01/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-9-28 13/01/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-187-28 29/09/2022 Madrid Descargar