RICHARDSON RFPD SPAIN SL

Activa

AVDA DE EUROPA 21 (ALCOBENDAS).
 Alcobendas, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 04/06/2024

AUDRIA SL

Auditor
Nombramiento: 05/12/2023

GARCIA ALVAREZ ANGELA

Apoderado
Nombramiento: 05/12/2023

DE SANTIS DANIELE

Apoderado
Nombramiento: 05/12/2023

MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 05/12/2023

PEGUEROLES VALLES LLUIS GONCAGA

Apoderado
Nombramiento: 05/12/2023

PEREIRA DOS SANTOS ANTONIO CARLOS

Apoderado
Cese: 13/01/2023

GARCIA LOPEZ FERNANDO

Apoderado
Cese: 13/01/2023

STANSBURY CHRISTOPHER DAVID

Apoderado
Cese: 13/01/2023

SHAW JOHN PAUL

Apoderado
Cese: 13/01/2023

UNDIKS EMMA JULISSA

Apoderado
Cese: 13/01/2023

KOPLITZ MARCUS PAUL

Apoderado
Cese: 13/10/2022

STANSBURY CHRISTOPHER DAVID

Administrador solidario
Nombramiento: 13/10/2022

SEIDLITZ RICHARD AUSTIN

Administrador solidario
Cese: 27/03/2020

TARPINIAN GREGORY

Consejero
Cese: 27/03/2020

BRUEDERL GEORG

Consejero
Cese: 27/03/2020

BRUEDERL GEORG

Presidente
Cese: 27/03/2020

STANSBURY CHRISTOPHER DAVID

Consejero
Cese: 27/03/2020

MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL

Secretario no consejero
Cese: 27/03/2020

TARPINIAN GREGORY

Apoderado
Cese: 27/03/2020

LOPEZ DONOSO PEDRO

Apoderado solidario
Nombramiento: 27/03/2020

STANSBURY CHRISTOPHER DAVID

Administrador solidario
Nombramiento: 27/03/2020

BRUEDERL GEORG

Administrador solidario
Nombramiento: 27/03/2020

MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE-MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2020

ARANA KNIRSCH SILVESTRE

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2020

BRAGADO LORENZO FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2020

PRIEGO LUQUE MARIA DOLORES

Apoderado
Nombramiento: 22/10/2019

GAYO REBOLLO JAVIER

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/10/2019

LOPEZ DONOSO PEDRO

Apoderado solidario
Nombramiento: 03/05/2019

SHAW JOHN PAUL

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2019

UNDIKS EMMA JULISSA

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2019

KOPLITZ MARCUS PAUL

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2019

NOREEN KENNETH ERIC

Apoderado
Nombramiento: 03/05/2019

SCOTT JASON E

Apoderado
Cese: 16/11/2018

LOPEZ DONOSO PEDRO

Secretario no consejero
Cese: 16/11/2018

LOPEZ DONOSO PEDRO

Apoderado
Cese: 16/11/2018

REILLY PAUL J

Apoderado
Nombramiento: 16/11/2018

MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL

Secretario no consejero
Nombramiento: 16/11/2018

TARPINIAN GREGORY

Apoderado
Nombramiento: 16/11/2018

STANSBURY CHRISTOPHER DAVID

Apoderado
Nombramiento: 16/11/2018

BRUEDERL GEORG

Apoderado
Nombramiento: 16/11/2018

MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE-MANUEL

Apoderado
Cese: 18/05/2017

RIAÑO GONZALEZ JUAN LUIS

Apoderado
Cese: 18/05/2017

MCNALLY BRIAN

Apoderado
Cese: 18/05/2017

BROWN PETER

Apoderado
Cese: 18/05/2017

GARCIA LOPEZ FERNANDO

Apoderado
Cese: 17/01/2017

REILLY PAUL J

Consejero
Nombramiento: 17/01/2017

STANSBURY CHRISTOPHER DAVID

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por RICHARDSON RFPD SPAIN SL

04/06/2024 Detalles del anuncio (252303) Datos registrales: S 8 , H M 507150, I/A 20 (28.05.24).

  • Nombramientos

    Auditor: AUDRIA SL.

05/12/2023 Detalles del anuncio (518651) Datos registrales: T 38224 , F 221, S 8, H M 507150, I/A 19 (28.11.23).

  • Nombramientos

    Apoderado: GARCIA ALVAREZ ANGELA;DE SANTIS DANIELE;MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL;PEGUEROLES VALLES LLUIS GONCAGA;PEREIRA DOS SANTOS ANTONIO CARLOS.

13/01/2023 Detalles del anuncio (20001) Datos registrales: T 38224 , F 221, S 8, H M 507150, I/A 18 ( 5.01.23).

  • Revocaciones

    Apoderado: GARCIA LOPEZ FERNANDO;STANSBURY CHRISTOPHER DAVID;SHAW JOHN PAUL;UNDIKS EMMA JULISSA;KOPLITZ MARCUS PAUL.

13/10/2022 Detalles del anuncio (449242) Datos registrales: T 38224 , F 221, S 8, H M 507150, I/A 17 ( 5.10.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: STANSBURY CHRISTOPHER DAVID.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: SEIDLITZ RICHARD AUSTIN.

27/03/2020 Detalles del anuncio (134818) Datos registrales: T 38224 , F 220, S 8, H M 507150, I/A 16 (20.03.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: TARPINIAN GREGORY;BRUEDERL GEORG. Presidente: BRUEDERL GEORG. Consejero: STANSBURY CHRISTOPHER DAVID. SecreNoConsj: MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL.

  • Revocaciones

    Apoderado: TARPINIAN GREGORY. Apo.Sol.: LOPEZ DONOSO PEDRO.

  • Nombramientos

    Adm. Solid.: STANSBURY CHRISTOPHER DAVID;BRUEDERL GEORG. Apoderado: MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE-MANUEL;ARANA KNIRSCH SILVESTRE;BRAGADO LORENZO FRANCISCO JAVIER;PRIEGO LUQUE MARIA DOLORES.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.

22/10/2019 Detalles del anuncio (437533) Datos registrales: T 38224 , F 220, S 8, H M 507150, I/A 15 (15.10.19).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: GAYO REBOLLO JAVIER;LOPEZ DONOSO PEDRO.

03/05/2019 Detalles del anuncio (189107) Datos registrales: T 38224 , F 219, S 8, H M 507150, I/A 14 (24.04.19).

  • Nombramientos

    Apoderado: SHAW JOHN PAUL;UNDIKS EMMA JULISSA;KOPLITZ MARCUS PAUL;NOREEN KENNETH ERIC;SCOTT JASON E.

16/11/2018 Detalles del anuncio (457609) Datos registrales: T 38224 , F 213, S 8, H M 507150, I/A 13 ( 7.11.18).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: LOPEZ DONOSO PEDRO.

  • Revocaciones

    Apoderado: LOPEZ DONOSO PEDRO;REILLY PAUL J.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL. Apoderado: TARPINIAN GREGORY;STANSBURY CHRISTOPHER DAVID;BRUEDERL GEORG;MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE-MANUEL.

18/05/2017 Detalles del anuncio (206042) Datos registrales: T 28151 , F 110, S 8, H M 507150, I/A 12 ( 9.05.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: RIAÑO GONZALEZ JUAN LUIS;MCNALLY BRIAN;BROWN PETER;GARCIA LOPEZ FERNANDO.

17/01/2017 Detalles del anuncio (23528) Datos registrales: T 28151 , F 110, S 8, H M 507150, I/A 11 (10.01.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: REILLY PAUL J.

  • Nombramientos

    Consejero: STANSBURY CHRISTOPHER DAVID.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 19

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-106-28 04/06/2024 Madrid Descargar
BORME-A-2023-231-28 05/12/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-9-28 13/01/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-196-28 13/10/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2020-61-28 27/03/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-203-28 22/10/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-83-28 03/05/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-220-28 16/11/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2017-92-28 18/05/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-11-28 17/01/2017 Madrid Descargar