PROCOM DESARROLLOS URBANOS SA

Activa

C/ DOCTOR FLEMING 53 - BAJO IZQ (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 24/03/2022

DIRECTORES DE TRANSICION MANAGEMENT SL

Administrador único
Nombramiento: 24/03/2022

PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR

Representante
Nombramiento: 19/10/2017

ALVAREZ-NOVOA ROMERO RAFAEL

Apoderado solidario
Cese: 19/10/2017

ADVOCAAT JOHANNES WILHELMUS ARNOLDUS

Apoderado
Cese: 19/10/2017

PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR

Apoderado mancomunado
Cese: 19/10/2017

MARIATEGUI VALDES GONZALO

Apoderado mancomunado
Cese: 19/10/2017

GONZALEZ VAZQUEZ RAUL

Apoderado mancomunado
Cese: 19/10/2017

MARIATEGUI VALDES GONZALO

Apoderado
Cese: 12/08/2015

DIRECTORES DE TRANSICION FINANCE SL

Consejero
Cese: 12/08/2015

LIMSAR INVERSIONES ENERGETICAS SL

Consejero
Cese: 12/08/2015

LIMSAR INVERSIONES ENERGETICAS SL

Presidente
Cese: 12/08/2015

DIRECTORES DE TRANSICION FINANCE SL

Consejero delegado
Cese: 12/08/2015

ALBION REAL ESTATE MANAGEMENT SL

Consejero
Cese: 12/08/2015

PRPZ MANAGEMENT BV

Consejero
Cese: 12/08/2015

PRPZ MANAGEMENT II BV

Consejero
Cese: 12/08/2015

PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR

Representante
Cese: 12/08/2015

LOPEZ-IBOR MAYOR VICENTE MANUEL

Representante
Cese: 12/08/2015

DIEZ BAUMANN CARLOS ALEXANDRE

Secretario no consejero
Cese: 12/08/2015

CABALLERO FRANCOIS PIERRE

Representante
Cese: 12/08/2015

VAN DER VAT MENNO

Representante
Cese: 12/08/2015

JAN VAN RIEL REINOUT DIRK

Representante
Cese: 12/08/2015

RAFOLS VIVES ROSER

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 12/08/2015

DIRECTORES DE TRANSICION MANAGEMENT SL

Administrador único
Nombramiento: 12/08/2015

PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR

Representante
Nombramiento: 03/08/2015

VAN DER VAT MENNO

Representante
Nombramiento: 03/08/2015

JAN VAN RIEL REINOUT DIRK

Representante
Nombramiento: 03/08/2015

PRPZ MANAGEMENT BV

Consejero
Nombramiento: 03/08/2015

PRPZ MANAGEMENT II BV

Consejero
Nombramiento: 09/06/2015

MARIATEGUI VALDES GONZALO

Apoderado
Cese: 24/12/2014

PRPZ MANAGEMENT BV

Consejero
Cese: 24/12/2014

PRPZ MANAGEMENT II BV

Consejero
Cese: 24/12/2014

VAN DER VAT MENNO

Representante
Cese: 24/12/2014

DE GROOT MAXIMILIAAN

Representante
Cese: 24/12/2014

ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JORGE

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 24/12/2014

GONZALEZ VAZQUEZ RAUL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 15/12/2014

GRANT THORNTON SLP

Auditor
Nombramiento: 13/12/2013

GRANT THORNTON SLP

Auditor
Cese: 17/05/2013

ADVOCAAT JOHANNES WILHELMUS ARNOLDUS

Representante
Nombramiento: 17/05/2013

VAN DER VAT MENNO

Representante

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por PROCOM DESARROLLOS URBANOS SA

29/11/2022 Detalles del anuncio (523934) Datos registrales: T 23186 , F 97, S 8, H M 314490, I/A 49 (22.11.22).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 253.980,00 Euros. Resultante Suscrito: 106.020,00 Euros.

24/03/2022 Detalles del anuncio (131298) Datos registrales: T 23186 , F 96, S 8, H M 314490, I/A 48 (17.03.22).

  • Reelecciones

    Adm. Unico: DIRECTORES DE TRANSICION MANAGEMENT SL. Representan: PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR.

19/10/2017 Detalles del anuncio (411514) Datos registrales: T 23186 , F 93, S 8, H M 314490, I/A 47 (10.10.17).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: ALVAREZ-NOVOA ROMERO RAFAEL.

19/10/2017 Detalles del anuncio (411513) Datos registrales: T 23186 , F 93, S 8, H M 314490, I/A 46 (10.10.17).

  • Revocaciones

    Apoderado: ADVOCAAT JOHANNES WILHELMUS ARNOLDUS. Apo.Manc.: PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR;MARIATEGUI VALDES GONZALO;GONZALEZ VAZQUEZ RAUL.Apoderado: MARIATEGUI VALDES GONZALO.

19/10/2017 Detalles del anuncio (411512) Datos registrales: T 23186 , F 93, S 8, H M 314490, I/A 45 (10.10.17).

  • Cambio de domicilio social

    C/ DOCTOR FLEMING 53 - BAJO IZQ (MADRID).

14/08/2015 Detalles del anuncio (338799) Datos registrales: T 23186 , F 92, S 8, H M 314490, I/A 44 ( 6.08.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 9.640.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 360.000,00 Euros.

12/08/2015 Detalles del anuncio (335851) Datos registrales: T 23186 , F 92, S 8, H M 314490, I/A 43 ( 4.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DIRECTORES DE TRANSICION FINANCE SL;LIMSAR INVERSIONES ENERGETICAS SL. Presidente: LIMSAR INVERSIONES ENERGETICAS SL. Con.Delegado: DIRECTORES DE TRANSICION FINANCE SL. Consejero: ALBION REAL ESTATE MANAGEMENT SL;PRPZ MANAGEMENT BV;PRPZ MANAGEMENT II BV. Representan: PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR;LOPEZ-IBOR MAYOR VICENTE MANUEL. SecreNoConsj: DIEZ BAUMANN CARLOS ALEXANDRE. Representan: CABALLERO FRANCOIS PIERRE;VAN DER VAT MENNO;JAN VAN RIEL REINOUT DIRK. VsecrNoConsj: RAFOLS VIVES ROSER.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: DIRECTORES DE TRANSICION MANAGEMENT SL. Representan: PARDO DE ANDRADE IGNACIO GASPAR.

  • Modificaciones Estatutarias

    SE HAN MODIFICADO LOS ARTICULOS 18, 22, 25, 32, 36 Y 39 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SUPRESION DE LOS ARTICULOS 26 A 31, 33 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

03/08/2015 Detalles del anuncio (321804) Datos registrales: T 23186 , F 91, S 8, H M 314490, I/A 42 (23.07.15).

  • Nombramientos

    Representan: VAN DER VAT MENNO;JAN VAN RIEL REINOUT DIRK. Consejero: PRPZ MANAGEMENT BV;PRPZ MANAGEMENT II BV.

22/06/2015 Detalles del anuncio (252889) Datos registrales: T 23186 , F 91, S 8, H M 314490, I/A 41 (12.06.15).

  • Cambio de domicilio social

    C/ FRANCISCO GERVAS NUMERO 14, 1º (MADRID).

09/06/2015 Detalles del anuncio (231663) Datos registrales: T 23186 , F 90, S 8, H M 314490, I/A 40 ( 1.06.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: MARIATEGUI VALDES GONZALO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 40

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-227-28 29/11/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-58-28 24/03/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2017-200-28 19/10/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-200-28 19/10/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-200-28 19/10/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2015-154-28 14/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-152-28 12/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-145-28 03/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-115-28 22/06/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-106-28 09/06/2015 Madrid Descargar