PREMIUM PLUS SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 21/08/2014 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2014 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2014 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2014 | DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2014 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero |
| Cese: 21/08/2014 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Presidente |
| Cese: 21/08/2014 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero |
| Cese: 21/08/2014 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Secretario |
| Cese: 21/08/2014 | BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA |
Consejero |
| Cese: 21/08/2014 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero |
| Cese: 21/08/2014 | CAMARA ARCOS ANDRES |
Consejero |
| Cese: 21/08/2014 | DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Cese: 21/08/2014 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2014 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2014 | BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2014 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2014 | CAMARA ARCOS ANDRES |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2014 | DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2014 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2014 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Presidente |
| Nombramiento: 21/08/2014 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2014 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Secretario |
| Nombramiento: 21/08/2014 | DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2014 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | GARCIA VELASCO MARIA GLORIA |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2012 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2012 | CAMARA ARCOS ANDRES |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2012 | GARCIA VELASCO MARIA GLORIA |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | CAMARA ARCOS ANDRES |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | ABAD CAMARILLO JOSE LUIS |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | ABAD CAMARILLO JOSE LUIS |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2012 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Presidente |
| Cese: 21/08/2012 | SANCHEZ CUENCA JUAN JOSE |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero |
| Cese: 21/08/2012 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2012 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 21/08/2012 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Secretario |
| Cese: 21/08/2012 | SANCHEZ CUENCA JUAN JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2012 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2012 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Presidente |
| Nombramiento: 21/08/2012 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2012 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Secretario |
| Nombramiento: 21/08/2012 | BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2012 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2012 | CAMARA ARCOS ANDRES |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2012 | DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Nombramiento: 21/08/2012 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2012 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2012 | BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2012 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2012 | CAMARA ARCOS ANDRES |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 21/08/2012 | DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 05/01/2009 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero |
| Cese: 05/01/2009 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero |
| Cese: 05/01/2009 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Presidente |
| Cese: 05/01/2009 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Secretario |
| Cese: 05/01/2009 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 05/01/2009 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 05/01/2009 | CUENCA VALLS ARACELI |
Consejero |
| Cese: 05/01/2009 | CUENCA VALLS ARACELI |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 05/01/2009 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero |
| Nombramiento: 05/01/2009 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 05/01/2009 | SANCHEZ CUENCA JUAN JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 05/01/2009 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Presidente |
| Nombramiento: 05/01/2009 | DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 05/01/2009 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 05/01/2009 | SANCHEZ GARCIA JOSE |
Secretario |
| Nombramiento: 05/01/2009 | SANCHEZ CUENCA JUAN JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por PREMIUM PLUS SL
11/12/2017 Detalles del anuncio (483637) Datos registrales: T 411 , F 16, S 8, H SA 13592, I/A 7 (16.11.17).
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: ARTICULO 4º.- Domicilio y sucursales. La sociedad tiene su domicilio social en SALAMANCA, CP 37002, EN LA CALLE VILLAR Y MACLAS, NUMERO 2, 2ºC. El traslado del domicilio social dentro y fuera del mismo término municipal no exige acuerdo de la Junta General de socios.
- Cambio de domicilio social
C/ VILLAR Y MACIAS 2 2 C (SALAMANCA).
24/06/2016 Detalles del anuncio (267833) Datos registrales: T 411 , F 15, S 8, H SA 13592, I/A 6 ( 9.06.16).
- Ampliación de Capital
Capital: 16.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 271.500,00 Euros.
- Ampliación de Capital
Capital: 16.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 287.500,00 Euros.
- Ampliación de Capital
Capital: 8.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 295.500,00 Euros.
21/08/2014 Detalles del anuncio (342028) Datos registrales: T 411 , F 15, S 8, H SA 13592, I/A 5 ( 1.08.14).
- Nombramientos
Cons.Del.Man: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO;SANCHEZ GARCIA JOSE;GAMERO RODRIGUEZ JOSE;DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER.
21/08/2014 Detalles del anuncio (342027) Datos registrales: T 411 , F 15, S 8, H SA 13592, I/A 4 ( 1.08.14).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO. Presidente: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO. Consejero: SANCHEZ GARCIA JOSE. Secretario: SANCHEZ GARCIA JOSE. Consejero: BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA;GAMERO RODRIGUEZ JOSE;CAMARA ARCOS ANDRES;DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Man: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO;SANCHEZ GARCIA JOSE;BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA;GAMERO RODRIGUEZ JOSE;CAMARA ARCOS ANDRES;DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER.
- Nombramientos
Consejero: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO. Presidente: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO. Consejero: SANCHEZ GARCIA JOSE. Secretario: SANCHEZ GARCIA JOSE. Consejero: DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER;GAMERO RODRIGUEZ JOSE.
21/08/2012 Detalles del anuncio (349205) Datos registrales: T 411 , F 14, S 8, H SA 13592, I/A 3 ( 1.08.12).
- Ceses/Dimisiones
Cons.Del.Man: GARCIA VELASCO MARIA GLORIA;GAMERO RODRIGUEZ JOSE;CAMARA ARCOS ANDRES. Consejero: GARCIA VELASCO MARIA GLORIA;GAMERO RODRIGUEZ JOSE;CAMARA ARCOS ANDRES;ABAD CAMARILLO JOSE LUIS. Cons.Del.Man: ABAD CAMARILLO JOSE LUIS. Presidente: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO. Consejero: SANCHEZ CUENCA JUAN JOSE;DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO;SANCHEZ GARCIA JOSE. Cons.Del.Man: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO;SANCHEZ GARCIA JOSE. Secretario: SANCHEZ GARCIA JOSE. Cons.Del.Man: SANCHEZ CUENCA JUAN JOSE.
- Nombramientos
Consejero: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO. Presidente: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO. Consejero: SANCHEZ GARCIA JOSE. Secretario: SANCHEZ GARCIA JOSE. Consejero: BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA;GAMERO RODRIGUEZ JOSE;CAMARA ARCOS ANDRES;DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Man: DE LA MOTA NICOLAS CORREA PABLO;SANCHEZ GARCIA JOSE;BLAZQUEZ PINILLA JOSE MARIA;GAMERO RODRIGUEZ JOSE;CAMARA ARCOS ANDRES;DEL CASTILLO RIVERO FRANCISCO JAVIER.
31/08/2011 Detalles del anuncio (395642)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2011) Año: 2010
04/11/2010 Detalles del anuncio (991945)
- Depósitos de cuentas anuales
(Octubre de 2010) Año: 2009
21/10/2010 Detalles del anuncio (390315) Datos registrales: T 411 , F 14, S 8, H SA 13592, I/A 2 ( 6.10.10).
- Cambio de domicilio social
C/ LOS OLMOS 5-7 (SALAMANCA).
27/05/2010 Detalles del anuncio (212512) Datos registrales: T 20776 , F 192, S 8, H M 368106, I/A 6 (18.05.10).
- Ampliación de Capital
Capital: 84.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 255.500,00 Euros.
30/03/2010 Detalles del anuncio (144867)
- Depósitos de cuentas anuales
(Marzo de 2010) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 13
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2017-233-37 | 11/12/2017 | Salamanca | Descargar |
| BORME-A-2016-120-37 | 24/06/2016 | Salamanca | Descargar |
| BORME-A-2014-158-37 | 21/08/2014 | Salamanca | Descargar |
| BORME-A-2014-158-37 | 21/08/2014 | Salamanca | Descargar |
| BORME-A-2012-159-37 | 21/08/2012 | Salamanca | Descargar |
| BORME-B-2011-166-37 | 31/08/2011 | Salamanca | Descargar |
| BORME-B-2010-212-37 | 04/11/2010 | Salamanca | Descargar |
| BORME-A-2010-203-37 | 21/10/2010 | Salamanca | Descargar |
| BORME-A-2010-100-28 | 27/05/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2010-60-28 | 30/03/2010 | Madrid | Descargar |