PARC EOLIC COLL DEL PANISSOT SL

Activa

C/ OQUENDO 23 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 13/02/2015

ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL

Administrador único
Cese: 13/02/2015

ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 13/02/2015

ECOWIND ENERGY SL

Administrador único
Nombramiento: 13/02/2015

MORIÑIGO SOTELO ABELARDO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 13/02/2015

BOSCH MIQUEL GEMMA

Apoderado
Cese: 13/02/2015

IÑIGUEZ BLANCO JUAN MARIA

Apoderado
Cese: 13/02/2015

CUEVAS DE MIGUEL JOSE CARLOS

Apoderado
Cese: 13/02/2015

BOSCH MIQUEL GEMMA

Apoderado
Cese: 13/02/2015

VERDURA GOMEZ DANIEL

Apoderado
Cese: 13/02/2015

HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL

Apoderado mancomunado
Cese: 13/02/2015

GARCIA GARCIA MARIA

Apoderado mancomunado
Cese: 13/02/2015

NAVAZO CUADRADO PABLO

Apoderado solidario
Cese: 12/08/2013

NICOLAS GALLOT

Apoderado
Nombramiento: 12/08/2013

HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 12/08/2013

GARCIA GARCIA MARIA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 12/08/2013

NAVAZO CUADRADO PABLO

Apoderado solidario
Cese: 12/08/2013

ALSTOM WIND SL

Administrador único
Cese: 12/08/2013

ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 12/08/2013

ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL

Administrador único
Nombramiento: 12/08/2013

ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 23/12/2011

SANMARTI AMAT JOAN

Apoderado
Cese: 23/12/2011

OLIVA RAMS ROSA MARIA

Apoderado
Nombramiento: 23/12/2011

VERDURA GOMEZ DANIEL

Apoderado
Cese: 25/11/2011

SANMARTI AMAT JOAN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 25/11/2011

ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 13/01/2011

BOSCH MIQUEL GEMMA

Apoderado
Cese: 19/01/2010

CAMARA SERRANO JUAN MARIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 19/01/2010

SANMARTI AMAT JOAN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 14/12/2009

ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES SL

Administrador único
Nombramiento: 14/12/2009

CAMARA SERRANO JUAN MARIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por PARC EOLIC COLL DEL PANISSOT SL

07/04/2015 Detalles del anuncio (144367) Datos registrales: T 33050 , F 176, S 8, H M 594941, I/A 2 (27.03.15).

  • Cambio de domicilio social

    C/ OQUENDO 23 (MADRID).

13/02/2015 Detalles del anuncio (64302) Datos registrales: T 43883 , F 51, S 8, H B 260589, I/A 26 ( 3.02.15).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: ECOWIND ENERGY SL. REPR.143 RRM: MORIÑIGO SOTELO ABELARDO.

  • Otros Conceptos

    DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO:ECOWIND ENERGY SL.

13/02/2015 Detalles del anuncio (64301) Datos registrales: T 43883 , F 51, S 8, H B 260589, I/A 25 ( 3.02.15).

  • Revocaciones

    APODERADO: BOSCH MIQUEL GEMMA;IÑIGUEZ BLANCO JUAN MARIA;CUEVAS DE MIGUEL JOSE CARLOS;BOSCH MIQUEL GEMMA;VERDURA GOMEZ DANIEL. APOD.MANCOMU: HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL;GARCIA GARCIA MARIA. APODERAD.SOL: NAVAZO CUADRADO PABLO.

12/08/2013 Detalles del anuncio (358711) Datos registrales: T 43883 , F 51, S 8, H B 260589, I/A 24 ( 1.08.13).

  • Revocaciones

    APODERADO: NICOLAS GALLOT.

12/08/2013 Detalles del anuncio (358710) Datos registrales: T 40455 , F 40, S 8, H B 260589, I/A 23 ( 1.08.13).

  • Nombramientos

    APOD.MANCOMU: HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL;GARCIA GARCIA MARIA. APODERAD.SOL: NAVAZO CUADRADO PABLO.

12/08/2013 Detalles del anuncio (358709) Datos registrales: T 40455 , F 39, S 8, H B 260589, I/A 22 ( 1.08.13).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: ALSTOM WIND SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.

23/12/2011 Detalles del anuncio (510562) Datos registrales: T 40455 , F 38, S 8, H B 260589, I/A 21 (12.12.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: SANMARTI AMAT JOAN;OLIVA RAMS ROSA MARIA.

  • Nombramientos

    APODERADO: VERDURA GOMEZ DANIEL.

25/11/2011 Detalles del anuncio (471614) Datos registrales: T 40455 , F 38, S 8, H B 260589, I/A 20 (15.11.11).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: SANMARTI AMAT JOAN.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.

13/01/2011 Detalles del anuncio (11910) Datos registrales: T 40455 , F 38, S 8, H B 260589, I/A 19 (30.12.10).

  • Nombramientos

    APODERADO: BOSCH MIQUEL GEMMA.

28/06/2010 Detalles del anuncio (256259) Datos registrales: T 40455 , F 37, S 8, H B 260589, I/A 18 (17.06.10).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 75.248,00 Euros. Resultante Suscrito: 93.258,00 Euros.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 15

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-64-28 07/04/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-30-08 13/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-30-08 13/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-152-08 12/08/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-152-08 12/08/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-152-08 12/08/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-242-08 23/12/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-224-08 25/11/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-8-08 13/01/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-121-08 28/06/2010 Barcelona Descargar