PARC EOLIC COLL DEL PANISSOT SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 13/02/2015 | ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL |
Administrador único |
| Cese: 13/02/2015 | ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 13/02/2015 | ECOWIND ENERGY SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 13/02/2015 | MORIÑIGO SOTELO ABELARDO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 13/02/2015 | BOSCH MIQUEL GEMMA |
Apoderado |
| Cese: 13/02/2015 | IÑIGUEZ BLANCO JUAN MARIA |
Apoderado |
| Cese: 13/02/2015 | CUEVAS DE MIGUEL JOSE CARLOS |
Apoderado |
| Cese: 13/02/2015 | BOSCH MIQUEL GEMMA |
Apoderado |
| Cese: 13/02/2015 | VERDURA GOMEZ DANIEL |
Apoderado |
| Cese: 13/02/2015 | HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 13/02/2015 | GARCIA GARCIA MARIA |
Apoderado mancomunado |
| Cese: 13/02/2015 | NAVAZO CUADRADO PABLO |
Apoderado solidario |
| Cese: 12/08/2013 | NICOLAS GALLOT |
Apoderado |
| Nombramiento: 12/08/2013 | HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 12/08/2013 | GARCIA GARCIA MARIA |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 12/08/2013 | NAVAZO CUADRADO PABLO |
Apoderado solidario |
| Cese: 12/08/2013 | ALSTOM WIND SL |
Administrador único |
| Cese: 12/08/2013 | ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 12/08/2013 | ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 12/08/2013 | ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 23/12/2011 | SANMARTI AMAT JOAN |
Apoderado |
| Cese: 23/12/2011 | OLIVA RAMS ROSA MARIA |
Apoderado |
| Nombramiento: 23/12/2011 | VERDURA GOMEZ DANIEL |
Apoderado |
| Cese: 25/11/2011 | SANMARTI AMAT JOAN |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 25/11/2011 | ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 13/01/2011 | BOSCH MIQUEL GEMMA |
Apoderado |
| Cese: 19/01/2010 | CAMARA SERRANO JUAN MARIA |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 19/01/2010 | SANMARTI AMAT JOAN |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 14/12/2009 | ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 14/12/2009 | CAMARA SERRANO JUAN MARIA |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por PARC EOLIC COLL DEL PANISSOT SL
07/04/2015 Detalles del anuncio (144367) Datos registrales: T 33050 , F 176, S 8, H M 594941, I/A 2 (27.03.15).
- Cambio de domicilio social
C/ OQUENDO 23 (MADRID).
13/02/2015 Detalles del anuncio (64302) Datos registrales: T 43883 , F 51, S 8, H B 260589, I/A 26 ( 3.02.15).
- Revocaciones
ADM.UNICO: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.
- Nombramientos
ADM.UNICO: ECOWIND ENERGY SL. REPR.143 RRM: MORIÑIGO SOTELO ABELARDO.
- Otros Conceptos
DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO:ECOWIND ENERGY SL.
13/02/2015 Detalles del anuncio (64301) Datos registrales: T 43883 , F 51, S 8, H B 260589, I/A 25 ( 3.02.15).
- Revocaciones
APODERADO: BOSCH MIQUEL GEMMA;IÑIGUEZ BLANCO JUAN MARIA;CUEVAS DE MIGUEL JOSE CARLOS;BOSCH MIQUEL GEMMA;VERDURA GOMEZ DANIEL. APOD.MANCOMU: HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL;GARCIA GARCIA MARIA. APODERAD.SOL: NAVAZO CUADRADO PABLO.
12/08/2013 Detalles del anuncio (358711) Datos registrales: T 43883 , F 51, S 8, H B 260589, I/A 24 ( 1.08.13).
- Revocaciones
APODERADO: NICOLAS GALLOT.
12/08/2013 Detalles del anuncio (358710) Datos registrales: T 40455 , F 40, S 8, H B 260589, I/A 23 ( 1.08.13).
- Nombramientos
APOD.MANCOMU: HERNANDEZ MARQUINA JUAN MANUEL;GARCIA GARCIA MARIA. APODERAD.SOL: NAVAZO CUADRADO PABLO.
12/08/2013 Detalles del anuncio (358709) Datos registrales: T 40455 , F 39, S 8, H B 260589, I/A 22 ( 1.08.13).
- Revocaciones
ADM.UNICO: ALSTOM WIND SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.
- Nombramientos
ADM.UNICO: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.
23/12/2011 Detalles del anuncio (510562) Datos registrales: T 40455 , F 38, S 8, H B 260589, I/A 21 (12.12.11).
- Revocaciones
APODERADO: SANMARTI AMAT JOAN;OLIVA RAMS ROSA MARIA.
- Nombramientos
APODERADO: VERDURA GOMEZ DANIEL.
25/11/2011 Detalles del anuncio (471614) Datos registrales: T 40455 , F 38, S 8, H B 260589, I/A 20 (15.11.11).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: SANMARTI AMAT JOAN.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: ROSELL MASJUAN FRANCESC XAVIER.
13/01/2011 Detalles del anuncio (11910) Datos registrales: T 40455 , F 38, S 8, H B 260589, I/A 19 (30.12.10).
- Nombramientos
APODERADO: BOSCH MIQUEL GEMMA.
28/06/2010 Detalles del anuncio (256259) Datos registrales: T 40455 , F 37, S 8, H B 260589, I/A 18 (17.06.10).
- Ampliación de Capital
Capital: 75.248,00 Euros. Resultante Suscrito: 93.258,00 Euros.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 15
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2015-64-28 | 07/04/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-30-08 | 13/02/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-30-08 | 13/02/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-152-08 | 12/08/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-152-08 | 12/08/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2013-152-08 | 12/08/2013 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2011-242-08 | 23/12/2011 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2011-224-08 | 25/11/2011 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2011-8-08 | 13/01/2011 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2010-121-08 | 28/06/2010 | Barcelona | Descargar |