OGILVY INTERACTIVE SA
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 03/09/2019 | PRATS SIERRA OSCAR CESAR |
Consejero |
| Cese: 30/08/2019 | SANTACANA GOMEZ JORGE |
Consejero |
| Nombramiento: 30/08/2019 | JEAN MICHEL PELTIER |
Consejero |
| Nombramiento: 30/08/2019 | PRATS SIERRA OSCAR CESAR |
Consejero |
| Cese: 30/08/2019 | SANTACANA GOMEZ JORGE |
Apoderado |
| Cese: 12/04/2019 | MUNICIO DEL CAMPO CARLOS |
Apoderado |
| Nombramiento: 12/04/2019 | MARIAN CRESPO GASPAR ALFONSO |
Apoderado solidario mancomunado |
| Cese: 07/04/2016 | GORTAZAR ROTAECHE BEGOÑA |
Apoderado |
| Cese: 07/04/2016 | ALAVEDRA COMAS JORGE MANUEL |
Apoderado |
| Cese: 07/04/2016 | SYLVIE MICHAUT |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 03/11/2015 | PAUL ODONNELL |
Consejero |
| Nombramiento: 03/11/2015 | PAUL ODONNELL |
Presidente |
| Cese: 17/06/2015 | TELLEZ GREGORIO FRANCISCO JOSE |
Apoderado |
| Cese: 17/06/2015 | ALVARO RUIZ LUCIA |
Apoderado |
| Nombramiento: 17/06/2015 | SYLVIE MICHAUT |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 17/06/2015 | CLIMENT PLA MARIA CONCEPCION |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 17/06/2015 | HERNANDEZ REDONDO JESUS MANUEL |
Apoderado mancomunado |
| Nombramiento: 17/06/2015 | BOCOS MARTIN TERESA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 17/06/2015 | LOPEZ MORAS ALEXIA MARIA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 17/06/2015 | RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRA |
Apoderado solidario |
| Cese: 11/03/2015 | PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE |
Consejero |
| Cese: 11/03/2015 | PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE |
Presidente |
| Nombramiento: 11/03/2015 | PAUL ODONNELL |
Presidente |
| Nombramiento: 11/03/2015 | SANTACANA GOMEZ JORGE |
Consejero |
| Nombramiento: 29/08/2014 | PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE |
Consejero |
| Nombramiento: 29/08/2014 | PRATS SIERRA OSCAR CESAR |
Consejero |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por OGILVY INTERACTIVE SA
24/12/2020 Detalles del anuncio (458235) Datos registrales: T 42729 , F 78, S 8, H B 185513, I/A 40 (16.12.20).
- Extinción
06/11/2019 Detalles del anuncio (457888) Datos registrales: T 42729 , F 78, S 8, H B 185513, I/A 39 (28.10.19).
- Otros Conceptos
DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, ACCIONISTA UNICO: WPP HOLDINGS SPAIN S.L.
03/09/2019 Detalles del anuncio (377549) Datos registrales: T 42729 , F 74, S 8, H B 185513, I/A 30 N (23.08.19).
- Cancelaciones de oficio de nombramientos
CONSEJERO: PRATS SIERRA OSCAR CESAR.
30/08/2019 Detalles del anuncio (375068) Datos registrales: T 42729 , F 78, S 8, H B 185513, I/A 36 (23.08.19).
- Revocaciones
CONSEJERO: SANTACANA GOMEZ JORGE.
- Nombramientos
CONSEJERO: JEAN MICHEL PELTIER.
30/08/2019 Detalles del anuncio (375074) Datos registrales: T 42729 , F 78, S 8, H B 185513, I/A 38 (23.08.19).
- Nombramientos
CONSEJERO: PRATS SIERRA OSCAR CESAR.
30/08/2019 Detalles del anuncio (375071) Datos registrales: T 42729 , F 78, S 8, H B 185513, I/A 37 (23.08.19).
- Revocaciones
APODERADO: SANTACANA GOMEZ JORGE.
12/04/2019 Detalles del anuncio (165146) Datos registrales: T 42729 , F 76, S 8, H B 185513, I/A 35 ( 4.04.19).
- Revocaciones
APODERADO: MUNICIO DEL CAMPO CARLOS.
- Nombramientos
APOD.SOL/MAN: MARIAN CRESPO GASPAR ALFONSO.
07/04/2016 Detalles del anuncio (152902) Datos registrales: T 42729 , F 76, S 8, H B 185513, I/A 34 (31.03.16).
- Revocaciones
APODERADO: GORTAZAR ROTAECHE BEGOÑA;ALAVEDRA COMAS JORGE MANUEL. APOD.MANCOMU: SYLVIE MICHAUT.
03/11/2015 Detalles del anuncio (441773) Datos registrales: T 42729 , F 75, S 8, H B 185513, I/A 33 (26.10.15).
- Nombramientos
CONSEJERO: PAUL ODONNELL. PRESIDENTE: PAUL ODONNELL.
17/06/2015 Detalles del anuncio (243181) Datos registrales: T 42729 , F 75, S 8, H B 185513, I/A 32 ( 8.06.15).
- Revocaciones
APODERADO: TELLEZ GREGORIO FRANCISCO JOSE;ALVARO RUIZ LUCIA.
- Nombramientos
APOD.MANCOMU: SYLVIE MICHAUT;CLIMENT PLA MARIA CONCEPCION;HERNANDEZ REDONDO JESUS MANUEL. APODERAD.SOL: BOCOS MARTIN TERESA;LOPEZ MORAS ALEXIA MARIA;RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRA.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 26
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2020-246-08 | 24/12/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-213-08 | 06/11/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-168-08 | 03/09/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-166-08 | 30/08/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-166-08 | 30/08/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-166-08 | 30/08/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-72-08 | 12/04/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-66-08 | 07/04/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-210-08 | 03/11/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-112-08 | 17/06/2015 | Barcelona | Descargar |