OGILVY ACTION BCN SA

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 02/09/2010

PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 02/09/2010

PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE

Presidente
Nombramiento: 02/09/2010

MUNICIO DEL CAMPO CARLOS

Consejero
Nombramiento: 02/09/2010

ALVAREZ DIAZ ALFONSO J

Consejero
Cese: 29/07/2010

OLAV VON ALLWOERDEN

Consejero
Cese: 31/08/2009

BLANCO VILLALBA RAQUEL

Secretario no consejero
Nombramiento: 31/08/2009

DIEZ VERGARA MAITANE

Secretario no consejero
Nombramiento: 31/08/2009

MENDEZ ZORI JOSE MARIA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 31/08/2009

MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA

Apoderado
Cese: 31/08/2009

LLANO BADIA DANIEL

Apoderado
Cese: 17/03/2009

LLANO BADIA DANIEL

Apoderado
Cese: 17/03/2009

LLANO BADIA DANIEL

Consejero
Nombramiento: 17/03/2009

LLANO BADIA DANIEL

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por OGILVY ACTION BCN SA

07/02/2011 Detalles del anuncio (50630) Datos registrales: T 41547 , F 2, S 8, H B 135046, I/A 32 ( 7.12.10).

  • Fe de erratas

    En el BORME no.241/2010 y con referencia 466017 EN LA REFERENCIA 466017 PUBLICADA EN EL BOLETIN NUMERO 241 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2010 DONDE SE LEE EXTINCION DE LA SOCIEDAD OGILVY ACTION BCN SA DEBE LEERSE DISOLUCION.

20/12/2010 Detalles del anuncio (466017) Datos registrales: T 41547 , F 2, S 8, H B 135046, I/A 32 ( 7.12.10).

  • Extinción

03/12/2010 Detalles del anuncio (448182) Datos registrales: T 41547 , F 1, S 8, H B 135046, I/A 31 (23.11.10).

  • Otros Conceptos

    SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: OGILVY ACTION SA.

04/11/2010 Detalles del anuncio (980117)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

02/09/2010 Detalles del anuncio (338523) Datos registrales: T 41547 , F 1, S 8, H B 135046, I/A 30 (20.08.10).

  • Nombramientos

    CONSEJERO: PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE. PRESIDENTE: PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE. CONSEJERO: MUNICIO DEL CAMPO CARLOS;ALVAREZ DIAZ ALFONSO J.

29/07/2010 Detalles del anuncio (297748) Datos registrales: T 41547 , F 1, S 8, H B 135046, I/A 29 (16.07.10).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: OLAV VON ALLWOERDEN.

27/11/2009 Detalles del anuncio (497225) Datos registrales: T 41547 , F 1, S 8, H B 135046, I/A 28 (18.11.09).

  • Cambio de objeto social

    LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVACION DE MARCA,EN TODAS SUS FACETAS,UTILIZANDO CUALQUIER TIPO DE SOPORTE,MEDIOS DE COMUNICACION,TANTO CONVENCIONALES COMO NO CONVENCIONALES,Y ESPACIOS,BIEN SEAN CENTROS COMERCIALES...

23/10/2009 Detalles del anuncio (725735)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2009) Año: 2008

31/08/2009 Detalles del anuncio (377300) Datos registrales: T 28395 , F 36, S 8, H B 135046, I/A 26 (19.08.09).

  • Revocaciones

    SECR.NO CONS: BLANCO VILLALBA RAQUEL.

  • Nombramientos

    SECR.NO CONS: DIEZ VERGARA MAITANE. V-SEC NO CON: MENDEZ ZORI JOSE MARIA. APODERADO: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA.

31/08/2009 Detalles del anuncio (377301) Datos registrales: T 28395 , F 36, S 8, H B 135046, I/A 27 (19.08.09).

  • Revocaciones

    APODERADO: LLANO BADIA DANIEL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2011-25-08 07/02/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-241-08 20/12/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-232-08 03/12/2010 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-212-08 04/11/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-169-08 02/09/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-144-08 29/07/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-227-08 27/11/2009 Barcelona Descargar
BORME-B-2009-203-08 23/10/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-165-08 31/08/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-165-08 31/08/2009 Barcelona Descargar