NUTRAL SA

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 12/07/2013

KPMG AUDITORES SL

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 06/06/2013

MARGALLO LOPEZ JOSE MARIA

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

SEGURA TOMAS MARIA DE LAS MERCEDES

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

LASIERRA MARCO JORGE

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

MATEO LOPEZ JUAN

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

PEREZ DIAZ ENRIQUE

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

SOLER LOPEZ TERESA

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

FERNANDEZ BALMON ROSARIO

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

MATEO LOPEZ JUAN

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2013

LASIERRA MARCO JORGE

Apoderado
Cese: 25/09/2012

MATEO ALUJAS JOSE-MARIA

Consejero delegado
Nombramiento: 02/08/2012

KPMG AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 02/08/2012

KPMG AUDITORES SL

Auditor de cuentas consolidadas
Cese: 05/07/2012

SCHOLMAN GISBERTUS JOHANNES

Consejero
Cese: 05/07/2012

VAN DER LAAN ANTONIUS TC

Consejero
Cese: 05/07/2012

VAN DER LAAN ANTONIUS TC

Presidente
Nombramiento: 05/07/2012

MATEO ALUJAS JOSE-MARIA

Consejero
Nombramiento: 05/07/2012

MARTINEZ SALCEDO ALBERTO

Consejero
Nombramiento: 05/07/2012

MATEO ALUJAS JOSE-MARIA

Presidente
Nombramiento: 05/07/2012

MATEO ALUJAS JOSE-MARIA

Consejero delegado
Cese: 11/06/2012

VAN DER LAAN ANTONIUS TC

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 11/06/2012

VAN DER LAAN ANTONIUS TC

Consejero
Nombramiento: 11/06/2012

SCHOLMAN GISBERTUS JOHANNES

Consejero
Nombramiento: 11/06/2012

VAN DER LAAN ANTONIUS TC

Presidente
Nombramiento: 11/06/2012

PEREZ DIAZ ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 11/06/2012

MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA

Vicesecretario
Nombramiento: 11/06/2012

DIEZ VERGARA MAITANE

Secretario no consejero
Cese: 06/06/2012

CRINCE MARCELIUS

Consejero
Cese: 06/06/2012

CUP MICHEL MARTINUS GERARDUS

Consejero
Nombramiento: 06/06/2012

PEREZ DIAZ ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 06/06/2012

CUP MICHEL MARTINUS GERARDUS

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por NUTRAL SA

30/04/2014 Detalles del anuncio (185910) Datos registrales: T 29958 , F 37, S 8, H M 91171, I/A 75 (15.04.14).

  • Otros Conceptos

    CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL. ( ART. 233.2 R.R.M.).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

13/02/2014 Detalles del anuncio (68060) Datos registrales: T 29958 , F 37, S 8, H M 91171, I/A 74-M ( 4.02.14).

  • Otros Conceptos

    Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral por el plazo de 6 meses, de coformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM, al ser absobida por la Sociedad domiciliada en Martorell, Barcelona, denominada CARGILL SL.

12/07/2013 Detalles del anuncio (317274) Datos registrales: T 29958 , F 36, S 8, H M 91171, I/A 74 ( 4.07.13).

  • Revocaciones

    Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL.

06/06/2013 Detalles del anuncio (259793) Datos registrales: T 29958 , F 35, S 8, H M 91171, I/A 73 (28.05.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: MARGALLO LOPEZ JOSE MARIA.

19/04/2013 Detalles del anuncio (187051) Datos registrales: T 29950 , F 34, S 8, H M 91171, I/A 70 (12.04.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: SEGURA TOMAS MARIA DE LAS MERCEDES.

19/04/2013 Detalles del anuncio (187053) Datos registrales: T 29950 , F 35, S 8, H M 91171, I/A 72 (12.04.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: LASIERRA MARCO JORGE;MATEO LOPEZ JUAN;PEREZ DIAZ ENRIQUE;SOLER LOPEZ TERESA.

19/04/2013 Detalles del anuncio (187052) Datos registrales: T 29950 , F 34, S 8, H M 91171, I/A 71 (12.04.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: FERNANDEZ BALMON ROSARIO;MATEO LOPEZ JUAN;LASIERRA MARCO JORGE.

04/02/2013 Detalles del anuncio (54636) Datos registrales: T 12268 , F 189, S 8, H M 91171, I/A 62M (26.01.13).

  • Otros Conceptos

    Comunicación del Auditor Deloitte SL de la imposibilidad absoluta de realizar la auditora del ejercicio 2011.-

25/09/2012 Detalles del anuncio (392736) Datos registrales: T 29958 , F 33, S 8, H M 91171, I/A 69 (14.09.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Con.Delegado: MATEO ALUJAS JOSE-MARIA.

25/09/2012 Detalles del anuncio (392735) Datos registrales: T 29958 , F 33, S 8, H M 91171, I/A 68 (14.09.12).

  • Sociedad Unipersonal

    CARGILL SL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 27

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2014-82-28 30/04/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-30-28 13/02/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-131-28 12/07/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-105-28 06/06/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-74-28 19/04/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-74-28 19/04/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-74-28 19/04/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-23-28 04/02/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-185-28 25/09/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-185-28 25/09/2012 Madrid Descargar