NUESTRAS CEPAS SL

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 02/03/2011

HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/03/2011

ALONSO SAEZ ROCIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2010

SABOVA BILYUKOVA STEFKA

Apoderado
Cese: 02/11/2010

GUTIERREZ GULLON ELENA

Apoderado solidario
Cese: 02/11/2010

CARNERO FERNANDEZ VICENTE

Apoderado solidario
Cese: 06/10/2010

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Consejero
Cese: 06/10/2010

TEJADA ALAMO ASTERIO

Consejero
Cese: 16/06/2010

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Vicepresidente
Cese: 16/06/2010

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Consejero delegado solidario
Cese: 16/06/2010

TEJADA ALAMO ASTERIO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 16/06/2010

SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA

Vicepresidente
Nombramiento: 16/06/2010

FIGUEROA VILLOTA IGNACIO JOAQUIN

Consejero
Cese: 10/08/2009

SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL

Consejero
Cese: 10/08/2009

SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA

Consejero
Cese: 10/08/2009

TEJADA ALAMO ASTERIO

Consejero
Cese: 10/08/2009

CARNERO FERNANDEZ VICENTE

Consejero
Cese: 10/08/2009

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Consejero
Cese: 10/08/2009

REBOLLO SIMON FELIX

Consejero
Cese: 10/08/2009

SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL

Presidente
Cese: 10/08/2009

SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL

Consejero delegado solidario
Cese: 10/08/2009

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Vicepresidente
Cese: 10/08/2009

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Consejero delegado solidario
Cese: 10/08/2009

SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA

Consejero delegado solidario
Cese: 10/08/2009

TEJADA ALAMO ASTERIO

Consejero delegado solidario
Cese: 10/08/2009

REBOLLO SIMON FELIX

Secretario
Nombramiento: 10/08/2009

SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL

Consejero
Nombramiento: 10/08/2009

SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL

Presidente
Nombramiento: 10/08/2009

SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 10/08/2009

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Consejero
Nombramiento: 10/08/2009

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Vicepresidente
Nombramiento: 10/08/2009

ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 10/08/2009

SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA

Consejero
Nombramiento: 10/08/2009

SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 10/08/2009

TEJADA ALAMO ASTERIO

Consejero
Nombramiento: 10/08/2009

TEJADA ALAMO ASTERIO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 10/08/2009

CARNERO FERNANDEZ VICENTE

Consejero
Nombramiento: 10/08/2009

HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 10/08/2009

HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS

Secretario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por NUESTRAS CEPAS SL

17/02/2012 Detalles del anuncio (80172) Datos registrales: T 626, L 417, F 91, S 8, H BU 2334, I/A 25 ( 9.02.12).

  • Cambio de denominación social

    BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN SL.

08/08/2011 Detalles del anuncio (253879)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2010

02/03/2011 Detalles del anuncio (94009) Datos registrales: T 626, L 417, F 90, S 8, H BU 2334, I/A 24 (21.02.11).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS;ALONSO SAEZ ROCIO.

02/11/2010 Detalles del anuncio (403504) Datos registrales: T 480, L 271, F 118, S 8, H BU 2334, I/A 22 (21.10.10).

  • Nombramientos

    Apoderado: SABOVA BILYUKOVA STEFKA.

02/11/2010 Detalles del anuncio (403505) Datos registrales: T 626, L 417, F 90, S 8, H BU 2334, I/A 23 (21.10.10).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: GUTIERREZ GULLON ELENA;CARNERO FERNANDEZ VICENTE.

06/10/2010 Detalles del anuncio (373497) Datos registrales: T 480, L 271, F 118, S 8, H BU 2334, I/A 21 (27.09.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA;TEJADA ALAMO ASTERIO.

28/07/2010 Detalles del anuncio (295577) Datos registrales: T 480, L 271, F 118, S 8, H BU 2334, I/A 20 (19.07.10).

  • Ampliación del Objeto Social

    Actividades inmobiliarias en general. Compraventa de bienes y servicios detelecomunicaciones,electricidad e informática. Fabricación y venta de equipos telefónicos.Invertir capitales en toda clase de empresa. Adquirir y enajenar valores mobiliarios. Promoción y distribución productos alimenticios.

17/06/2010 Detalles del anuncio (210414)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Junio de 2010) Año: 2009

16/06/2010 Detalles del anuncio (239181) Datos registrales: T 480, L 271, F 117, S 8, H BU 2334, I/A 19 ( 7.06.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Vicepresid.: ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA. Cons.Del.Sol: ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA;TEJADA ALAMO ASTERIO.

  • Nombramientos

    Vicepresid.: SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA. Consejero: FIGUEROA VILLOTA IGNACIO JOAQUIN.

01/09/2009 Detalles del anuncio (298894)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2009) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2012-34-09 17/02/2012 Burgos Descargar
BORME-B-2011-150-09 08/08/2011 Burgos Descargar
BORME-A-2011-42-09 02/03/2011 Burgos Descargar
BORME-A-2010-210-09 02/11/2010 Burgos Descargar
BORME-A-2010-210-09 02/11/2010 Burgos Descargar
BORME-A-2010-193-09 06/10/2010 Burgos Descargar
BORME-A-2010-143-09 28/07/2010 Burgos Descargar
BORME-B-2010-114-09 17/06/2010 Burgos Descargar
BORME-A-2010-113-09 16/06/2010 Burgos Descargar
BORME-B-2009-166-09 01/09/2009 Burgos Descargar