NUESTRAS CEPAS SL
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 02/03/2011 | HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 02/03/2011 | ALONSO SAEZ ROCIO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 02/11/2010 | SABOVA BILYUKOVA STEFKA |
Apoderado |
| Cese: 02/11/2010 | GUTIERREZ GULLON ELENA |
Apoderado solidario |
| Cese: 02/11/2010 | CARNERO FERNANDEZ VICENTE |
Apoderado solidario |
| Cese: 06/10/2010 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Consejero |
| Cese: 06/10/2010 | TEJADA ALAMO ASTERIO |
Consejero |
| Cese: 16/06/2010 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Vicepresidente |
| Cese: 16/06/2010 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 16/06/2010 | TEJADA ALAMO ASTERIO |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 16/06/2010 | SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 16/06/2010 | FIGUEROA VILLOTA IGNACIO JOAQUIN |
Consejero |
| Cese: 10/08/2009 | SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL |
Consejero |
| Cese: 10/08/2009 | SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA |
Consejero |
| Cese: 10/08/2009 | TEJADA ALAMO ASTERIO |
Consejero |
| Cese: 10/08/2009 | CARNERO FERNANDEZ VICENTE |
Consejero |
| Cese: 10/08/2009 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Consejero |
| Cese: 10/08/2009 | REBOLLO SIMON FELIX |
Consejero |
| Cese: 10/08/2009 | SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL |
Presidente |
| Cese: 10/08/2009 | SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 10/08/2009 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Vicepresidente |
| Cese: 10/08/2009 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 10/08/2009 | SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 10/08/2009 | TEJADA ALAMO ASTERIO |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 10/08/2009 | REBOLLO SIMON FELIX |
Secretario |
| Nombramiento: 10/08/2009 | SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL |
Consejero |
| Nombramiento: 10/08/2009 | SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL |
Presidente |
| Nombramiento: 10/08/2009 | SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 10/08/2009 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Consejero |
| Nombramiento: 10/08/2009 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 10/08/2009 | ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 10/08/2009 | SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA |
Consejero |
| Nombramiento: 10/08/2009 | SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 10/08/2009 | TEJADA ALAMO ASTERIO |
Consejero |
| Nombramiento: 10/08/2009 | TEJADA ALAMO ASTERIO |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 10/08/2009 | CARNERO FERNANDEZ VICENTE |
Consejero |
| Nombramiento: 10/08/2009 | HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 10/08/2009 | HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS |
Secretario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por NUESTRAS CEPAS SL
17/02/2012 Detalles del anuncio (80172) Datos registrales: T 626, L 417, F 91, S 8, H BU 2334, I/A 25 ( 9.02.12).
- Cambio de denominación social
BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN SL.
08/08/2011 Detalles del anuncio (253879)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2011) Año: 2010
02/03/2011 Detalles del anuncio (94009) Datos registrales: T 626, L 417, F 90, S 8, H BU 2334, I/A 24 (21.02.11).
- Nombramientos
Apo.Sol.: HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS;ALONSO SAEZ ROCIO.
02/11/2010 Detalles del anuncio (403504) Datos registrales: T 480, L 271, F 118, S 8, H BU 2334, I/A 22 (21.10.10).
- Nombramientos
Apoderado: SABOVA BILYUKOVA STEFKA.
02/11/2010 Detalles del anuncio (403505) Datos registrales: T 626, L 417, F 90, S 8, H BU 2334, I/A 23 (21.10.10).
- Revocaciones
Apo.Sol.: GUTIERREZ GULLON ELENA;CARNERO FERNANDEZ VICENTE.
06/10/2010 Detalles del anuncio (373497) Datos registrales: T 480, L 271, F 118, S 8, H BU 2334, I/A 21 (27.09.10).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA;TEJADA ALAMO ASTERIO.
28/07/2010 Detalles del anuncio (295577) Datos registrales: T 480, L 271, F 118, S 8, H BU 2334, I/A 20 (19.07.10).
- Ampliación del Objeto Social
Actividades inmobiliarias en general. Compraventa de bienes y servicios detelecomunicaciones,electricidad e informática. Fabricación y venta de equipos telefónicos.Invertir capitales en toda clase de empresa. Adquirir y enajenar valores mobiliarios. Promoción y distribución productos alimenticios.
17/06/2010 Detalles del anuncio (210414)
- Depósitos de cuentas anuales
(Junio de 2010) Año: 2009
16/06/2010 Detalles del anuncio (239181) Datos registrales: T 480, L 271, F 117, S 8, H BU 2334, I/A 19 ( 7.06.10).
- Ceses/Dimisiones
Vicepresid.: ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA. Cons.Del.Sol: ABAJO ALCALDE CARLOS MARIA;TEJADA ALAMO ASTERIO.
- Nombramientos
Vicepresid.: SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA. Consejero: FIGUEROA VILLOTA IGNACIO JOAQUIN.
01/09/2009 Detalles del anuncio (298894)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2009) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2012-34-09 | 17/02/2012 | Burgos | Descargar |
| BORME-B-2011-150-09 | 08/08/2011 | Burgos | Descargar |
| BORME-A-2011-42-09 | 02/03/2011 | Burgos | Descargar |
| BORME-A-2010-210-09 | 02/11/2010 | Burgos | Descargar |
| BORME-A-2010-210-09 | 02/11/2010 | Burgos | Descargar |
| BORME-A-2010-193-09 | 06/10/2010 | Burgos | Descargar |
| BORME-A-2010-143-09 | 28/07/2010 | Burgos | Descargar |
| BORME-B-2010-114-09 | 17/06/2010 | Burgos | Descargar |
| BORME-A-2010-113-09 | 16/06/2010 | Burgos | Descargar |
| BORME-B-2009-166-09 | 01/09/2009 | Burgos | Descargar |