NUBIOLA PIGMENTOS SL

Activa

CALLE VITORIA-GASTEIZ, 19
 Laudio/Llodio, Araba/Álava  (01400)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 13/05/2016

CASTILLO ARTETA ANGEL

Consejero
Cese: 13/05/2016

FRYDRYK SANDRA JANE

Consejero
Cese: 13/05/2016

PECORARA LUCA

Consejero
Cese: 13/05/2016

TORTAJADA GIRBES JOSE

Consejero
Cese: 13/05/2016

TORTAJADA GIRBES JOSE

Secretario
Nombramiento: 13/05/2016

BELL MATTHIAS PETER

Consejero
Nombramiento: 13/05/2016

DOS SANTOS PATROCINIO ANTONIO JOSE

Secretario
Nombramiento: 26/02/2016

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO RICARDO

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO RICARDO

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO ANDRES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO ANDRES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

PUERTOLAS CAPELLA JOSE

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO JOSE ORIOL

Apoderado
Cese: 28/01/2016

SOLE PEREZ JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

PUERTOLAS CAPELLA JOSE

Apoderado
Cese: 28/01/2016

MENDIVIL VALLE IGNACIO

Apoderado
Cese: 28/01/2016

RUIZ CASTRESANA FELIX

Apoderado
Cese: 28/01/2016

ENCINILLAS GOMEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 28/01/2016

GARCIA SEIJAS SANTIAGO

Apoderado
Cese: 28/01/2016

RUIZ CASTRESANA FELIX

Apoderado
Cese: 28/01/2016

PUERTOLAS CAPELLA JOSE

Apoderado
Cese: 28/01/2016

ENCINILLAS GOMEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 28/01/2016

GARCIA SEIJAS SANTIAGO

Apoderado
Cese: 28/01/2016

SOLE PEREZ JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

MENDIVIL VALLE IGNACIO

Apoderado
Cese: 28/01/2016

TEIXIDO BADAL JOSE

Apoderado
Cese: 28/01/2016

TEIXIDO BADAL JOSE

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO ANDRES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

ROGER NUBIOLA INES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO NURIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

TORRES ROSELL AGNEL

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO MONTSERRAT

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO NURIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

TORRES ROSELL AGNEL

Apoderado
Cese: 28/01/2016

SOLE PEREZ JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

BACHILLER ARRIBAS ALBERTO

Apoderado
Cese: 28/01/2016

SANCHEZ VILA VICTOR

Apoderado
Cese: 28/01/2016

LAZARO MARTINEZ SILVIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO ANDRES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

ROGER NUBIOLA INES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO MONTSERRAT

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO NURIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

TORRES ROSELL AGNEL

Apoderado
Cese: 28/01/2016

SOLE PEREZ JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO ANDRES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

ROGER NUBIOLA INES

Apoderado
Cese: 28/01/2016

NUBIOLA BELLIDO MONTSERRAT

Apoderado
Nombramiento: 28/01/2016

PASCUAL BARBERO PEDRO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 28/01/2016

BACHILLER ARRIBAS ALBERTO

Apoderado solidario
Nombramiento: 28/01/2016

THATE GRANADOS GUILLERMO

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/12/2015

VAN DER WILT GERRIT JACOBUS

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/12/2015

BAUER CHRISTOPH WALTER

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/12/2015

HEASLEY ELIZABETH

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 30/12/2015

CASTILLO ARTETA ANGEL

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 30/12/2015

ROGER TOMAS ANGELS

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/12/2015

TORTAJADA GIRBES JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/12/2015

CAÑIZARES LOPEZ VICENTE

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 24/09/2015

DOS SANTOS PATROCINIO ANTONIO JOSE

Consejero
Nombramiento: 24/09/2015

DOS SANTOS PATROCINIO ANTONIO JOSE

Consejero delegado
Cese: 11/09/2015

DEL RIO GALEOTE AGUSTIN

Vicesecretario
Cese: 11/09/2015

NUBIOLA BELLIDO ANDRES

Consejero
Cese: 11/09/2015

NUBIOLA BELLIDO RICARDO

Consejero
Cese: 11/09/2015

NUBIOLA BELLIDO ANDRES

Presidente
Cese: 11/09/2015

NUBIOLA BELLIDO NURIA

Consejero
Cese: 11/09/2015

NUBIOLA BELLIDO NURIA

Secretario
Nombramiento: 11/09/2015

TIMOTHY BINGLE JOHN

Apoderado
Nombramiento: 11/09/2015

BINDER DIETER

Consejero
Nombramiento: 11/09/2015

BINDER DIETER

Presidente
Nombramiento: 11/09/2015

TORTAJADA GIRBES JOSE

Consejero
Nombramiento: 11/09/2015

TORTAJADA GIRBES JOSE

Secretario
Nombramiento: 11/09/2015

PECORARA LUCA

Consejero
Nombramiento: 11/09/2015

FRYDRYK SANDRA JANE

Consejero
Nombramiento: 11/09/2015

CASTILLO ARTETA ANGEL

Consejero
Nombramiento: 31/07/2015

GRANT THORNTON SLP

Auditor
Cese: 17/12/2014

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Consejero
Cese: 17/12/2014

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Secretario
Nombramiento: 17/12/2014

NUBIOLA BELLIDO NURIA

Consejero
Nombramiento: 17/12/2014

NUBIOLA BELLIDO NURIA

Secretario
Nombramiento: 17/12/2014

DEL RIO GALEOTE AGUSTIN

Vicesecretario
Nombramiento: 17/12/2014

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Consejero
Nombramiento: 17/12/2014

NUBIOLA BELLIDO MERCEDES

Secretario
Nombramiento: 15/10/2014

GRANT THORNTON SLP

Auditor
Nombramiento: 13/12/2013

GRANT THORNTON SLP

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por NUBIOLA PIGMENTOS SL

13/05/2016 Detalles del anuncio (206272) Datos registrales: T 1599 , F 129, S 8, H VI 5558, I/A 39 ( 3.05.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CASTILLO ARTETA ANGEL;FRYDRYK SANDRA JANE;PECORARA LUCA;TORTAJADA GIRBES JOSE. Secretario: TORTAJADA GIRBES JOSE.

  • Nombramientos

    Consejero: BELL MATTHIAS PETER. Secretario: DOS SANTOS PATROCINIO ANTONIO JOSE.

26/02/2016 Detalles del anuncio (87569) Datos registrales: T 1599 , F 128, S 8, H VI 5558, I/A 38 (15.02.16).

  • Nombramientos

    Auditor: DELOITTE S.L.

28/01/2016 Detalles del anuncio (35631) Datos registrales: T 1524 , F 20, S 8, H VI 5558, I/A 37 (13.01.16).

  • Revocaciones

    Apoderado: NUBIOLA BELLIDO RICARDO;NUBIOLA BELLIDO RICARDO;NUBIOLA BELLIDO ANDRES;NUBIOLA BELLIDO ANDRES;PUERTOLAS CAPELLA JOSE;NUBIOLA BELLIDO JOSE ORIOL;SOLE PEREZ JOSE MARIA;PUERTOLAS CAPELLA JOSE;MENDIVIL VALLE IGNACIO;RUIZ CASTRESANA FELIX;ENCINILLAS GOMEZ MIGUEL ANGEL;GARCIA SEIJAS SANTIAGO;RUIZ CASTRESANA FELIX;PUERTOLAS CAPELLA JOSE;ENCINILLAS GOMEZ MIGUEL ANGEL;GARCIA SEIJAS SANTIAGO;SOLE PEREZ JOSE MARIA;MENDIVIL VALLE IGNACIO;TEIXIDO BADAL JOSE;TEIXIDO BADAL JOSE;NUBIOLA BELLIDO ANDRES;NUBIOLA BELLIDO MERCEDES;ROGER NUBIOLA INES;NUBIOLA BELLIDO NURIA;TORRES ROSELL AGNEL;NUBIOLA BELLIDO MERCEDES;NUBIOLA BELLIDO MONTSERRAT;NUBIOLA BELLIDO NURIA;TORRES ROSELL AGNEL;SOLE PEREZ JOSE MARIA;BACHILLER ARRIBAS ALBERTO;SANCHEZ VILA VICTOR;LAZARO MARTINEZ SILVIA;NUBIOLA BELLIDO ANDRES;NUBIOLA BELLIDO MERCEDES;ROGER NUBIOLA INES;NUBIOLA BELLIDO MONTSERRAT;NUBIOLA BELLIDO NURIA;TORRES ROSELL AGNEL;SOLE PEREZ JOSE MARIA;NUBIOLA BELLIDO ANDRES;NUBIOLA BELLIDO MERCEDES;ROGER NUBIOLA INES;NUBIOLA BELLIDO MONTSERRAT.

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: PASCUAL BARBERO PEDRO. Apo.Sol.: BACHILLER ARRIBAS ALBERTO;THATE GRANADOS GUILLERMO.

30/12/2015 Detalles del anuncio (528716) Datos registrales: T 1524 , F 18, S 8, H VI 5558, I/A 36 (21.12.15).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: VAN DER WILT GERRIT JACOBUS;BAUER CHRISTOPH WALTER. Apo.Manc.: HEASLEY ELIZABETH. Apo.Man.Soli: CASTILLO ARTETA ANGEL. Apo.Sol.: ROGER TOMAS ANGELS;TORTAJADA GIRBES JOSE. Apo.Man.Soli: CAÑIZARES LOPEZ VICENTE.

24/09/2015 Detalles del anuncio (386067) Datos registrales: T 1524 , F 18, S 8, H VI 5558, I/A 35 (31.08.15).

  • Nombramientos

    Consejero: DOS SANTOS PATROCINIO ANTONIO JOSE. Con.Delegado: DOS SANTOS PATROCINIO ANTONIO JOSE.

11/09/2015 Detalles del anuncio (372037) Datos registrales: T 1524 , F 17, S 8, H VI 5558, I/A 34 (17.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Vicesecret.: DEL RIO GALEOTE AGUSTIN. Consejero: NUBIOLA BELLIDO ANDRES;NUBIOLA BELLIDO RICARDO. Presidente: NUBIOLA BELLIDO ANDRES. Consejero: NUBIOLA BELLIDO NURIA. Secretario: NUBIOLA BELLIDO NURIA.

  • Nombramientos

    Apoderado: TIMOTHY BINGLE JOHN. Consejero: BINDER DIETER. Presidente: BINDER DIETER. Consejero: TORTAJADA GIRBES JOSE. Secretario: TORTAJADA GIRBES JOSE. Consejero: PECORARA LUCA;FRYDRYK SANDRA JANE;CASTILLO ARTETA ANGEL.

31/07/2015 Detalles del anuncio (317959) Datos registrales: T 1524 , F 17, S 8, H VI 5558, I/A 33 (20.07.15).

  • Reelecciones

    Auditor: GRANT THORNTON S.L.P.

17/12/2014 Detalles del anuncio (512847) Datos registrales: T 1524 , F 16, S 8, H VI 5558, I/A 32 ( 9.12.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: NUBIOLA BELLIDO MERCEDES. Secretario: NUBIOLA BELLIDO MERCEDES.

  • Nombramientos

    Consejero: NUBIOLA BELLIDO NURIA. Secretario: NUBIOLA BELLIDO NURIA. Vicesecret.: DEL RIO GALEOTE AGUSTIN.

  • Reelecciones

    Consejero: NUBIOLA BELLIDO MERCEDES. Secretario: NUBIOLA BELLIDO MERCEDES.

15/10/2014 Detalles del anuncio (412216) Datos registrales: T 1524 , F 16, S 8, H VI 5558, I/A 31 ( 3.10.14).

  • Reelecciones

    Auditor: GRANT THORNTON S.L.P.

28/02/2014 Detalles del anuncio (94058) Datos registrales: T 1524 , F 15, S 8, H VI 5558, I/A 30 (13.02.14).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    CORPORACION QUIMICA VHEM SL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 23

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2016-91-01 13/05/2016 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2016-39-01 26/02/2016 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2016-18-01 28/01/2016 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2015-248-01 30/12/2015 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2015-183-01 24/09/2015 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2015-174-01 11/09/2015 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2015-144-01 31/07/2015 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2014-240-01 17/12/2014 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2014-197-01 15/10/2014 Araba/Álava Descargar
BORME-A-2014-41-01 28/02/2014 Araba/Álava Descargar