METRONICS TECHNOLOGIES SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 02/01/2025 | PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL |
Auditor |
| Nombramiento: 10/06/2021 | AYERRA ARRARAS IÑAKI |
Apoderado |
| Nombramiento: 10/06/2021 | MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER |
Apoderado |
| Nombramiento: 10/06/2021 | DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES |
Apoderado |
| Cese: 08/04/2021 | URTASUN ABARZUZA JOSE MARIA |
Consejero |
| Cese: 08/04/2021 | DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES |
Consejero |
| Cese: 08/04/2021 | GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE |
Consejero |
| Cese: 08/04/2021 | CAMBRA BASARTE MANUEL |
Consejero |
| Cese: 08/04/2021 | MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Cese: 08/04/2021 | URTASUN ABARZUZA JOSE MARIA |
Presidente |
| Cese: 08/04/2021 | DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES |
Vicepresidente |
| Cese: 08/04/2021 | GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE |
Secretario |
| Cese: 08/04/2021 | DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES |
Consejero delegado |
| Cese: 08/04/2021 | GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE |
Consejero delegado |
| Cese: 08/04/2021 | MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 08/04/2021 | BARDENA21 SL |
Administrador único |
| Cese: 04/04/2016 | DOMINGUEZ EQUIZA FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Cese: 04/04/2016 | URTASUN ABARZUZA JOSE MARIA |
Consejero delegado |
| Cese: 04/04/2016 | GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE |
Apoderado |
| Nombramiento: 04/04/2016 | GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 04/04/2016 | MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER |
Consejero delegado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por METRONICS TECHNOLOGIES SL
02/01/2025 Detalles del anuncio (477) Datos registrales: S 8 , H NA 16387, I/A 12 (20.12.24).
- Nombramientos
Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL.
29/09/2021 Detalles del anuncio (434477) Datos registrales: T 800 , F 29, S 8, H NA 16387, I/A 11 (21.09.21).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.065,00 Euros.
- Escisión Parcial
Sociedades beneficiarias de la escisión: IDUS HPP SYSTEMS SL.
10/06/2021 Detalles del anuncio (282674) Datos registrales: T 800 , F 27, S 8, H NA 16387, I/A 9 ( 2.06.21).
- Nombramientos
Apoderado: AYERRA ARRARAS IÑAKI.
10/06/2021 Detalles del anuncio (282675) Datos registrales: T 800 , F 28, S 8, H NA 16387, I/A 10 ( 2.06.21).
- Nombramientos
Apoderado: MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER;DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES.
08/04/2021 Detalles del anuncio (160912) Datos registrales: T 800 , F 27, S 8, H NA 16387, I/A 8 (26.03.21).
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.
BARDENA21 SL.
- Ceses/Dimisiones
Consejero: URTASUN ABARZUZA JOSE MARIA;DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES;GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE;CAMBRA BASARTE MANUEL;MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER. Presidente: URTASUN ABARZUZA JOSE MARIA. Vicepresid.: DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES. Secretario: GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE. Con.Delegado: DE ORTE GLARIA BENITO ANDRES;GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE;MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER.
- Nombramientos
Adm. Unico: BARDENA21 SL.
- Otros Conceptos
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Designado DON CAMILO JOSE GUTIERREZ ARTOLA representante físico del Administrador Unico BARDENA21 SL.
19/06/2018 Detalles del anuncio (257698) Datos registrales: T 800 , F 26, S 8, H NA 16387, I/A 7 (31.05.18).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 935,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.065,00 Euros.
- Otros Conceptos
RENUMERADAS y ASIGNADAS las participaciones existentes tras la reducción, de la número uno a la catorce mil sesenta y cinco.
04/04/2016 Detalles del anuncio (146698) Datos registrales: T 800 , F 25, S 8, H NA 16387, I/A 6 (17.03.16).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DOMINGUEZ EQUIZA FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: URTASUN ABARZUZA JOSE MARIA.
- Revocaciones
Apoderado: GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE.
- Nombramientos
Con.Delegado: GUTIERREZ ARTOLA CAMILO JOSE;MERINO ZARDOYA FRANCISCO JAVIER.
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICADO el artículo 13º de los estatutos sociales, relativo al órgano de administración.
06/09/2011 Detalles del anuncio (439051)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2011) Año: 2010
10/08/2010 Detalles del anuncio (299604)
- Depósitos de cuentas anuales
(Julio de 2010) Año: 2009
10/09/2009 Detalles del anuncio (390136)
- Depósitos de cuentas anuales
(Agosto de 2009) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 10
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2025-1-31 | 02/01/2025 | Navarra | Descargar |
| BORME-A-2021-188-31 | 29/09/2021 | Navarra | Descargar |
| BORME-A-2021-109-31 | 10/06/2021 | Navarra | Descargar |
| BORME-A-2021-109-31 | 10/06/2021 | Navarra | Descargar |
| BORME-A-2021-65-31 | 08/04/2021 | Navarra | Descargar |
| BORME-A-2018-116-31 | 19/06/2018 | Navarra | Descargar |
| BORME-A-2016-63-31 | 04/04/2016 | Navarra | Descargar |
| BORME-B-2011-170-31 | 06/09/2011 | Navarra | Descargar |
| BORME-B-2010-152-31 | 10/08/2010 | Navarra | Descargar |
| BORME-B-2009-173-31 | 10/09/2009 | Navarra | Descargar |