MASPAD SL

Activa

CL TUSET NUM.23-25 P.1 PTA.7 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 24/08/2021

CABARROCAS RIERA ELENA

Apoderado mancomunado
Cese: 24/08/2021

MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 24/08/2021

CABARROCAS RIERA ELENA

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/08/2021

FIGUEREO BAULENAS PERE

Apoderado solidario
Nombramiento: 05/07/2019

CABARROCAS RIERA ELENA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 05/07/2019

MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL

Apoderado mancomunado
Cese: 19/06/2019

MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 19/06/2019

SAEZ MARTINEZ ANGEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 21/05/2019

BELMONTE RAMOS OSCAR

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 21/05/2019

MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 08/04/2016

BOSCH AYMERICH SL

Administrador solidario
Cese: 08/04/2016

ESCARPENTER FERRAN ANDRES

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 08/04/2016

CABARROCAS RIERA ELENA

Administrador conjunto
Nombramiento: 08/04/2016

BOSCH AYMERICH SL

Administrador conjunto
Nombramiento: 08/04/2016

BELMONTE RAMOS OSCAR

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 20/03/2015

BOSCH AYMERICH JOSE MARIA

Administrador
Cese: 20/03/2015

BOSCH AYMERICH JOSE MARIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 20/03/2015

ESCARPENTER FERRAN ANDRES

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 07/06/2012

BYA SL

Administrador solidario
Nombramiento: 07/06/2012

BOSCH AYMERICH JOSE MARIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 25/05/2012

NOLLA VARELA JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 25/11/2010

BOSCH AYMERICH JOSE MARIA

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por MASPAD SL

24/08/2021 Detalles del anuncio (393880) Datos registrales: T 46869 , F 152, S 8, H B 289323, I/A 16 (16.08.21).

  • Revocaciones

    APOD.MANCOMU: CABARROCAS RIERA ELENA;MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL.

24/08/2021 Detalles del anuncio (393887) Datos registrales: T 46869 , F 153, S 8, H B 289323, I/A 17 (16.08.21).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: CABARROCAS RIERA ELENA;FIGUEREO BAULENAS PERE.

19/05/2021 Detalles del anuncio (237410) Datos registrales: T 46869 , F 152, S 8, H B 289323, I/A 15 (10.05.21).

  • Cambio de domicilio social

    CL TUSET NUM.23-25 P.1 PTA.7 (BARCELONA).

05/07/2019 Detalles del anuncio (290444) Datos registrales: T 46869 , F 151, S 8, H B 289323, I/A 14 (27.06.19).

  • Nombramientos

    APOD.MANCOMU: CABARROCAS RIERA ELENA;MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL.

19/06/2019 Detalles del anuncio (265176) Datos registrales: T 46869 , F 151, S 8, H B 289323, I/A 13 (12.06.19).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: SAEZ MARTINEZ ANGEL.

21/05/2019 Detalles del anuncio (212986) Datos registrales: T 36440 , F 82, S 8, H B 289323, I/A 12 (13.05.19).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: BELMONTE RAMOS OSCAR.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: MARTINEZ NUÑEZ MARIA ISABEL.

08/09/2016 Detalles del anuncio (368721) Datos registrales: T 36440 , F 82, S 8, H B 289323, I/A 11 (31.08.16).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 10.806.843,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.892.270,00 Euros.

08/04/2016 Detalles del anuncio (155120) Datos registrales: T 36440 , F 81, S 8, H B 289323, I/A 10 (31.03.16).

  • Revocaciones

    ADM.SOLIDAR.: BOSCH AYMERICH SL. REPR.143 RRM: ESCARPENTER FERRAN ANDRES.

  • Nombramientos

    ADM.CONJUNTO: CABARROCAS RIERA ELENA;BOSCH AYMERICH SL. REPR.143 RRM: BELMONTE RAMOS OSCAR.

  • Otros Conceptos

    DETERMINACION DE LOS ACTIVOS ESENCIALES DE LA SOCIEDAD.

09/09/2015 Detalles del anuncio (368176) Datos registrales: T 36440 , F 81, S 8, H B 289323, I/A 9 (31.08.15).

  • Cambio de domicilio social

    CL CARAVEL.LA LA NIÑA Num.12 P.7 PTA.A (BARCELONA).

20/03/2015 Detalles del anuncio (117870) Datos registrales: T 36440 , F 81, S 8, H B 289323, I/A 8 (11.03.15).

  • Revocaciones

    ADMINISTR.: BOSCH AYMERICH JOSE MARIA. REPR.143 RRM: BOSCH AYMERICH JOSE MARIA.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: ESCARPENTER FERRAN ANDRES.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 19

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-162-08 24/08/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2021-162-08 24/08/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2021-93-08 19/05/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-127-08 05/07/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-115-08 19/06/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-94-08 21/05/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-172-08 08/09/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-67-08 08/04/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-172-08 09/09/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-54-08 20/03/2015 Barcelona Descargar