MAPA PLUS SA

Extinta

CALLE SAN SOTERO, 11 - PLT 2
Madrid  (28037)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 29/08/2023

SAIZ GONZALEZ ENRIQUE

Consejero
Cese: 29/08/2023

GARCIA GARRIDO RAFAEL

Consejero
Nombramiento: 09/01/2023

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 12/04/2022

CASANOVA SANCHEZ DE OCAÑA IGNACIO

Consejero
Cese: 12/04/2022

CASANOVA SANCHEZ DE OCAÑA IGNACIO

Presidente
Nombramiento: 12/04/2022

OÑATE DE MORA VIRGILIO

Consejero
Nombramiento: 12/04/2022

ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE

Consejero
Nombramiento: 12/04/2022

MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO

Presidente
Cese: 28/02/2022

HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN

Consejero
Nombramiento: 28/02/2022

SAIZ GONZALEZ ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 28/02/2022

GARCIA GARRIDO RAFAEL

Consejero
Cese: 07/10/2021

DIAZ GUTIERREZ ALBERTO

Consejero
Nombramiento: 07/10/2021

HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN

Consejero
Cese: 14/01/2021

MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA

Apoderado
Nombramiento: 14/01/2021

NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION

Apoderado
Nombramiento: 14/01/2021

NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 14/01/2021

ESTEBAN MORALES ARTURO

Apoderado mancomunado
Cese: 23/01/2020

ALEMANY HERRERA RAFAEL

Auditor
Cese: 23/01/2020

AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA

Auditor suplente
Nombramiento: 23/01/2020

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 15/10/2019

SERRANO GRANADO MARIA ISABEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 15/10/2019

LOPEZ DE GRACIA JAVIER

Apoderado solidario
Nombramiento: 15/10/2019

ESTEBAN MORALES ARTURO

Apoderado solidario
Nombramiento: 07/06/2019

DIAZ GUTIERREZ ALBERTO

Apoderado
Nombramiento: 07/06/2019

DIAZ GUTIERREZ CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 07/06/2019

NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION

Apoderado
Nombramiento: 07/06/2019

MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA

Apoderado
Nombramiento: 07/06/2019

BRAVO DIAZ JUAN CARLOS

Apoderado
Cese: 29/05/2019

EIROA GIMENEZ FELIX FERNANDO

Consejero
Cese: 29/05/2019

CORTES URBAN PEDRO

Consejero
Nombramiento: 29/05/2019

MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por MAPA PLUS SA

23/11/2023 Detalles del anuncio (500052) Datos registrales: T 39712 , F 103, S 8, H M 228581, I/A 24 (16.11.23).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

29/08/2023 Detalles del anuncio (383407) Datos registrales: T 39712 , F 103, S 8, H M 228581, I/A 23 (22.08.23).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: SAIZ GONZALEZ ENRIQUE;GARCIA GARRIDO RAFAEL.

09/01/2023 Detalles del anuncio (12484) Datos registrales: T 39712 , F 103, S 8, H M 228581, I/A 22 (30.12.22).

  • Reelecciones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

12/04/2022 Detalles del anuncio (166495) Datos registrales: T 39712 , F 102, S 8, H M 228581, I/A 21 ( 5.04.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CASANOVA SANCHEZ DE OCAÑA IGNACIO. Presidente: CASANOVA SANCHEZ DE OCAÑA IGNACIO.

  • Nombramientos

    Consejero: OÑATE DE MORA VIRGILIO;ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE. Presidente: MONTES PEREZ DEL REAL EDUARDO.

28/02/2022 Detalles del anuncio (88780) Datos registrales: T 39712 , F 102, S 8, H M 228581, I/A 20 (21.02.22).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN.

  • Nombramientos

    Consejero: SAIZ GONZALEZ ENRIQUE;GARCIA GARRIDO RAFAEL.

07/10/2021 Detalles del anuncio (445326) Datos registrales: T 39712 , F 101, S 8, H M 228581, I/A 19 (30.09.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO.

  • Nombramientos

    Consejero: HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN.

14/01/2021 Detalles del anuncio (14763) Datos registrales: T 39712 , F 100, S 8, H M 228581, I/A 18 ( 7.01.21).

  • Revocaciones

    Apoderado: MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA.

  • Nombramientos

    Apoderado: NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION. Apo.Manc.: NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION;ESTEBAN MORALES ARTURO.

23/01/2020 Detalles del anuncio (29938) Datos registrales: T 39712 , F 100, S 8, H M 228581, I/A 17 (16.01.20).

  • Revocaciones

    Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA.

  • Nombramientos

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

15/10/2019 Detalles del anuncio (427569) Datos registrales: T 13951 , F 205, S 8, H M 228581, I/A 16 ( 8.10.19).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: SERRANO GRANADO MARIA ISABEL;LOPEZ DE GRACIA JAVIER;ESTEBAN MORALES ARTURO.

07/06/2019 Detalles del anuncio (245959) Datos registrales: T 13951 , F 203, S 8, H M 228581, I/A 15 (31.05.19).

  • Nombramientos

    Apoderado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;DIAZ GUTIERREZ CARLOS;NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION;MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA;BRAVO DIAZ JUAN CARLOS.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 22

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2023-223-28 23/11/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-164-28 29/08/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2023-5-28 09/01/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2022-71-28 12/04/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2022-40-28 28/02/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2021-194-28 07/10/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-8-28 14/01/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2020-15-28 23/01/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2019-198-28 15/10/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-107-28 07/06/2019 Madrid Descargar