LUARNA EDICIONES SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 04/04/2019 | MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO |
Secretario no consejero |
| Cese: 04/04/2019 | VALENCIA DE ALCAZAR GONZALO |
Vicesecretario no consejero |
| Nombramiento: 04/04/2019 | LLOPART VIDAL MARIA MONTSERRAT |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 04/04/2019 | LLOPART VIDAL MARIA MONTSERRAT |
Apoderado |
| Nombramiento: 04/04/2019 | FERRER PARERA ANNA |
Apoderado |
| Nombramiento: 04/04/2019 | ELIAS MASDEU JOSEP MARIA |
Apoderado |
| Nombramiento: 04/04/2019 | MASIP BORRAS ADRIA GERARD |
Apoderado |
| Nombramiento: 03/05/2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
| Cese: 21/08/2017 | OLABARRI GORTAZAR PABLO |
Secretario no consejero |
| Cese: 21/08/2017 | MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO |
Vicesecretario no consejero |
| Nombramiento: 21/08/2017 | MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 21/08/2017 | VALENCIA DE ALCAZAR GONZALO |
Secretario no consejero |
| Cese: 20/12/2016 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 12/04/2016 | RUIZ SOTILLO DANIEL |
Apoderado |
| Nombramiento: 12/08/2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Auditor |
| Cese: 06/08/2015 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Secretario |
| Nombramiento: 06/08/2015 | OLABARRI GORTAZAR PABLO |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 06/08/2015 | MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO |
Vicesecretario no consejero |
| Nombramiento: 19/10/2012 | DEL PRADO GONZALEZ RODRIGO |
Apoderado |
| Cese: 08/03/2012 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Consejero |
| Cese: 08/03/2012 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Presidente |
| Cese: 08/03/2012 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Consejero |
| Cese: 08/03/2012 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Secretario |
| Cese: 08/03/2012 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Consejero delegado |
| Cese: 08/03/2012 | IGLESIAS BALBAS RUBEN LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 08/03/2012 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 08/03/2012 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Consejero |
| Nombramiento: 08/03/2012 | BEJAR SAIZ MAZA DAVID |
Consejero |
| Nombramiento: 08/03/2012 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Presidente |
| Nombramiento: 08/03/2012 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Secretario |
| Nombramiento: 08/03/2012 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 08/03/2012 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 10/12/2010 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Administrador único |
| Nombramiento: 10/12/2010 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 10/12/2010 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Presidente |
| Nombramiento: 10/12/2010 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Consejero |
| Nombramiento: 10/12/2010 | MENDEZ PEYDRO ALBERTO |
Secretario |
| Nombramiento: 10/12/2010 | QUIROS CASADO ANTONIO LUIS |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 10/12/2010 | IGLESIAS BALBAS RUBEN LUIS |
Consejero |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por LUARNA EDICIONES SL
09/03/2022 Detalles del anuncio (104794) Datos registrales: T 38785 , F 146, S 8, H M 474784, I/A 18 ( 2.03.22).
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 859/2021. FIRME: Si, Fecha de resolución 12/11/2021. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID. Juez: JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ.
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 859/2021. FIRME: Si, Fecha de resolución 12/11/2021. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID. Juez: JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ.
- Extinción
04/04/2019 Detalles del anuncio (151390) Datos registrales: T 38785 , F 146, S 8, H M 474784, I/A 17 (28.03.19).
- Ceses/Dimisiones
SecreNoConsj: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO. VsecrNoConsj: VALENCIA DE ALCAZAR GONZALO.
- Nombramientos
SecreNoConsj: LLOPART VIDAL MARIA MONTSERRAT. Apoderado: LLOPART VIDAL MARIA MONTSERRAT;FERRER PARERA ANNA;ELIAS MASDEU JOSEP MARIA;MASIP BORRAS ADRIA GERARD.
03/05/2018 Detalles del anuncio (189351) Datos registrales: T 26347 , F 92, S 8, H M 474784, I/A 15 (23.04.18).
- Reelecciones
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
05/09/2017 Detalles del anuncio (359801) Datos registrales: T 26347 , F 92, S 8, H M 474784, I/A 14 (25.08.17).
- Cambio de objeto social
: El análisis y reparación de cualquier tipo de dispositivo electrónico y de cualquiera de sus componentes, tales como smartphones, tablets, dispositivos de lectura electrónica, impresoras y escaners 3D, robótica educativa, juguetes electrónicos, así como de cualquier otro tipo de dispositivo....
21/08/2017 Detalles del anuncio (342109) Datos registrales: T 26347 , F 91, S 8, H M 474784, I/A 13 ( 7.08.17).
- Ceses/Dimisiones
SecreNoConsj: OLABARRI GORTAZAR PABLO. VsecrNoConsj: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO.
- Nombramientos
SecreNoConsj: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO;VALENCIA DE ALCAZAR GONZALO.
20/12/2016 Detalles del anuncio (513963) Datos registrales: T 26347 , F 91, S 8, H M 474784, I/A 12 (12.12.16).
- Ceses/Dimisiones
Cons.Del.Sol: QUIROS CASADO ANTONIO LUIS.
19/07/2016 Detalles del anuncio (300267) Datos registrales: T 26347 , F 91, S 8, H M 474784, I/A 11 (11.07.16).
- Cambio de objeto social
El análisis y reparación de cualquier tipo de dispositivo electrónico y de cualquiera de sus componentes, tales como smartphones, tableas, dispositivos de lectura electrónica, impresoras y escaners 3D, robótica educativa, juguetes electrónicos, así como de cualquier otro tipo de dispositivo. La edic.
30/05/2016 Detalles del anuncio (228503) Datos registrales: T 26347 , F 90, S 8, H M 474784, I/A 10 (18.05.16).
- Ampliación del Objeto Social
La divulgación en materia de tecnología, la organización e impartición de formación en el uso y desarrollo de la misma, a todos los niveles, potenciando la formación online de forma coherente con la evolución de la tecnología que promueve...
12/04/2016 Detalles del anuncio (159562) Datos registrales: T 26347 , F 90, S 8, H M 474784, I/A 9 ( 4.04.16).
- Nombramientos
Apoderado: RUIZ SOTILLO DANIEL.
12/08/2015 Detalles del anuncio (335313) Datos registrales: T 26347 , F 89, S 8, H M 474784, I/A 8 (31.07.15).
- Nombramientos
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-47-28 | 09/03/2022 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-66-28 | 04/04/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2018-84-28 | 03/05/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-169-28 | 05/09/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2017-158-28 | 21/08/2017 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-240-28 | 20/12/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-137-28 | 19/07/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-101-28 | 30/05/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-69-28 | 12/04/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-152-28 | 12/08/2015 | Madrid | Descargar |