LEOMOTOR SL

Activa

CARRETERA HINIESTA, S/N - PARC 71
Zamora  (49025)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 30/01/2025

NAVARRO GUERRERO JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 30/01/2025

LAFUENTE TORCAL EDUARDO

Apoderado
Nombramiento: 14/11/2024

DARROSA AMOEDO SAMUEL

Apoderado
Nombramiento: 14/11/2024

MENDEZ ROMERO ELENA ANTONIA

Apoderado
Nombramiento: 14/11/2024

MARTINEZ CANSECO CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 12/01/2024

VACIERO AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 08/09/2022

PIERNAVIEJA MUÑIZ FELIX ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 30/12/2020

CENTIUM AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 30/12/2020

VACIERO AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 03/10/2019

CENTIUM AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 26/01/2017

CALLEJA PINILLA AUDITORA SL

Auditor
Nombramiento: 20/02/2014

CALLEJA PINILLA AUDITORA SL

Auditor
Nombramiento: 05/04/2013

CODON FRUTOS LUIS MIGUEL

Apoderado
Cese: 24/05/2011

OREJAS IBAN JOSE MIGUEL

Consejero
Cese: 24/05/2011

OREJAS IBAN JOSE MIGUEL

Presidente
Cese: 24/05/2011

OREJAS TAGARRO DANIEL

Consejero
Cese: 24/05/2011

TAGARRO DOMINGUEZ ANA MARIA

Consejero
Cese: 24/05/2011

OREJAS IBAN MARIA CARMEN YUKI

Consejero
Cese: 24/05/2011

OREJAS TAGARRO DIANA

Consejero
Cese: 24/05/2011

OREJAS TAGARRO RAQUEL

Consejero
Cese: 24/05/2011

OREJAS TAGARRO RAUL

Consejero
Cese: 24/05/2011

OREJAS TAGARRO DANIEL

Consejero delegado
Cese: 24/05/2011

OREJAS TAGARRO DANIEL

Secretario
Nombramiento: 24/05/2011

OREJAS TAGARRO DANIEL

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por LEOMOTOR SL

30/01/2025 Detalles del anuncio (49008) Datos registrales: S 8 , H ZA 1352, I/A 53 (20.01.25).

  • Nombramientos

    Apoderado: NAVARRO GUERRERO JAVIER;LAFUENTE TORCAL EDUARDO.

14/11/2024 Detalles del anuncio (489437) Datos registrales: S 8 , H ZA 1352, I/A 52 ( 7.11.24).

  • Nombramientos

    Apoderado: DARROSA AMOEDO SAMUEL;MENDEZ ROMERO ELENA ANTONIA;MARTINEZ CANSECO CARLOS.

12/01/2024 Detalles del anuncio (19452) Datos registrales: T 290 , F 90, S 8, H ZA 1352, I/A 50 ( 8.01.24).

  • Reelecciones

    Auditor: VACIERO AUDITORES SL.

08/09/2022 Detalles del anuncio (407662) Datos registrales: T 290 , F 90, S 8, H ZA 1352, I/A 49 ( 1.09.22).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: PIERNAVIEJA MUÑIZ FELIX ANGEL.

30/12/2020 Detalles del anuncio (468626) Datos registrales: T 290 , F 90, S 8, H ZA 1352, I/A 48 (17.12.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Auditor: CENTIUM AUDITORES SL.

  • Nombramientos

    Auditor: VACIERO AUDITORES SL.

03/10/2019 Detalles del anuncio (412624) Datos registrales: T 257 , F 14, S 8, H ZA 1352, I/A 47 (25.09.19).

  • Nombramientos

    Auditor: CENTIUM AUDITORES SL.

29/12/2017 Detalles del anuncio (512936) Datos registrales: T 257 , F 14, S 8, H ZA 1352, I/A 46 (15.12.17).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 82.036,50 Euros. Resultante Suscrito: 549.013,50 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-.

26/01/2017 Detalles del anuncio (43365) Datos registrales: T 257 , F 14, S 8, H ZA 1352, I/A 44 (18.01.17).

  • Nombramientos

    Auditor: CALLEJA PINILLA AUDITORA SL.

20/02/2014 Detalles del anuncio (81496) Datos registrales: T 257 , F 13, S 8, H ZA 1352, I/A 44 (10.02.14).

  • Nombramientos

    Auditor: CALLEJA PINILLA AUDITORA SL.

05/04/2013 Detalles del anuncio (160491) Datos registrales: T 257 , F 13, S 8, H ZA 1352, I/A 43 (22.03.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: CODON FRUTOS LUIS MIGUEL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 19

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2025-20-49 30/01/2025 Zamora Descargar
BORME-A-2024-220-49 14/11/2024 Zamora Descargar
BORME-A-2024-9-49 12/01/2024 Zamora Descargar
BORME-A-2022-172-49 08/09/2022 Zamora Descargar
BORME-A-2020-249-49 30/12/2020 Zamora Descargar
BORME-A-2019-190-49 03/10/2019 Zamora Descargar
BORME-A-2017-246-49 29/12/2017 Zamora Descargar
BORME-A-2017-18-49 26/01/2017 Zamora Descargar
BORME-A-2014-35-49 20/02/2014 Zamora Descargar
BORME-A-2013-64-49 05/04/2013 Zamora Descargar