LAURMAR 07 INVERSIONES SICAV SA
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 12/01/2012 | PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA |
Apoderado |
| Nombramiento: 12/01/2012 | GASSO NAVARRO MARIA- CONCEPCION |
Apoderado |
| Cese: 27/12/2011 | PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA |
Consejero |
| Cese: 27/12/2011 | PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA |
Presidente |
| Cese: 27/12/2011 | GARCIA CUESTA JUAN MANUEL |
Secretario |
| Nombramiento: 27/12/2011 | GASSO NAVARRO ANTONIO |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 27/12/2011 | GASSO NAVARRO CONCEPCION |
Consejero |
| Nombramiento: 27/12/2011 | GASSO NAVARRO CONCEPCION |
Presidente |
| Nombramiento: 10/08/2011 | DELOITTE SL |
Auditor |
| Cese: 17/08/2010 | DE AZQUETA ENCIO PEDRO |
Consejero |
| Nombramiento: 17/08/2010 | CHURRUCA AZLOR DE ARAGON JAIME |
Consejero |
| Nombramiento: 17/08/2010 | SANTACURZ IBIRICU JUAN-ANTONIO |
Consejero |
| Nombramiento: 17/08/2010 | ESPINO BAEZ CESAREO |
Consejero |
| Nombramiento: 17/08/2010 | DELOITTE SL |
Auditor |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por LAURMAR 07 INVERSIONES SICAV SA
01/03/2012 Detalles del anuncio (101489) Datos registrales: T 24403 , F 60, S 8, H M 438889, I/A 7 (20.02.12).
- Cambio de denominación social
PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA.
12/01/2012 Detalles del anuncio (15092) Datos registrales: T 24403 , F 60, S 8, H M 438889, I/A 6 ( 2.01.12).
- Revocaciones
Apoderado: PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA.
- Nombramientos
Apoderado: GASSO NAVARRO MARIA- CONCEPCION.
27/12/2011 Detalles del anuncio (517012) Datos registrales: T 24403 , F 59, S 8, H M 438889, I/A 5 (15.12.11).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA. Presidente: PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA. Secretario: GARCIA CUESTA JUAN MANUEL.
- Nombramientos
SecreNoConsj: GASSO NAVARRO ANTONIO. Consejero: GASSO NAVARRO CONCEPCION. Presidente: GASSO NAVARRO CONCEPCION.
10/08/2011 Detalles del anuncio (333565) Datos registrales: T 24403 , F 59, S 8, H M 438889, I/A 4 (29.07.11).
- Reelecciones
Auditor: DELOITTE SL.
26/10/2010 Detalles del anuncio (898723)
- Depósitos de cuentas anuales
(Octubre de 2010) Año: 2009
17/08/2010 Detalles del anuncio (322504) Datos registrales: T 24403 , F 59, S 8, H M 438889, I/A 3 ( 5.08.10).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DE AZQUETA ENCIO PEDRO.
- Nombramientos
Consejero: CHURRUCA AZLOR DE ARAGON JAIME;SANTACURZ IBIRICU JUAN-ANTONIO;ESPINO BAEZ CESAREO.
- Reelecciones
Auditor: DELOITTE SL.
20/11/2009 Detalles del anuncio (914954)
- Depósitos de cuentas anuales
(Noviembre de 2009) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 7
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2012-43-28 | 01/03/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-8-28 | 12/01/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-244-28 | 27/12/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-152-28 | 10/08/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2010-206-28 | 26/10/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-157-28 | 17/08/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2009-222-28 | 20/11/2009 | Madrid | Descargar |