LAURMAR 07 INVERSIONES SICAV SA

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 12/01/2012

PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA

Apoderado
Nombramiento: 12/01/2012

GASSO NAVARRO MARIA- CONCEPCION

Apoderado
Cese: 27/12/2011

PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA

Consejero
Cese: 27/12/2011

PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA

Presidente
Cese: 27/12/2011

GARCIA CUESTA JUAN MANUEL

Secretario
Nombramiento: 27/12/2011

GASSO NAVARRO ANTONIO

Secretario no consejero
Nombramiento: 27/12/2011

GASSO NAVARRO CONCEPCION

Consejero
Nombramiento: 27/12/2011

GASSO NAVARRO CONCEPCION

Presidente
Nombramiento: 10/08/2011

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 17/08/2010

DE AZQUETA ENCIO PEDRO

Consejero
Nombramiento: 17/08/2010

CHURRUCA AZLOR DE ARAGON JAIME

Consejero
Nombramiento: 17/08/2010

SANTACURZ IBIRICU JUAN-ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 17/08/2010

ESPINO BAEZ CESAREO

Consejero
Nombramiento: 17/08/2010

DELOITTE SL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por LAURMAR 07 INVERSIONES SICAV SA

01/03/2012 Detalles del anuncio (101489) Datos registrales: T 24403 , F 60, S 8, H M 438889, I/A 7 (20.02.12).

  • Cambio de denominación social

    PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA.

12/01/2012 Detalles del anuncio (15092) Datos registrales: T 24403 , F 60, S 8, H M 438889, I/A 6 ( 2.01.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA.

  • Nombramientos

    Apoderado: GASSO NAVARRO MARIA- CONCEPCION.

27/12/2011 Detalles del anuncio (517012) Datos registrales: T 24403 , F 59, S 8, H M 438889, I/A 5 (15.12.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA. Presidente: PABLOS FERNANDEZ MARIA TERESA. Secretario: GARCIA CUESTA JUAN MANUEL.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: GASSO NAVARRO ANTONIO. Consejero: GASSO NAVARRO CONCEPCION. Presidente: GASSO NAVARRO CONCEPCION.

10/08/2011 Detalles del anuncio (333565) Datos registrales: T 24403 , F 59, S 8, H M 438889, I/A 4 (29.07.11).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

26/10/2010 Detalles del anuncio (898723)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

17/08/2010 Detalles del anuncio (322504) Datos registrales: T 24403 , F 59, S 8, H M 438889, I/A 3 ( 5.08.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: DE AZQUETA ENCIO PEDRO.

  • Nombramientos

    Consejero: CHURRUCA AZLOR DE ARAGON JAIME;SANTACURZ IBIRICU JUAN-ANTONIO;ESPINO BAEZ CESAREO.

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

20/11/2009 Detalles del anuncio (914954)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2009) Año: 2008

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 7

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2012-43-28 01/03/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-8-28 12/01/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-244-28 27/12/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-152-28 10/08/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-206-28 26/10/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-157-28 17/08/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-222-28 20/11/2009 Madrid Descargar