LABORATORIOS MEDICHIP SL

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 22/09/2009

ANDRES JUSTI IRENE

Secretario no consejero
Cese: 22/09/2009

PEREZ MOSQUERA ANTONIO

Consejero
Cese: 22/09/2009

PEREZ MOSQUERA ANTONIO

Presidente
Cese: 22/09/2009

SERRANO SACRISTAN PABLO

Consejero
Cese: 22/09/2009

FLEMING MICHAEL W

Consejero
Nombramiento: 22/09/2009

ANDRES JUSTI IRENE

Liquidador solidario
Nombramiento: 22/09/2009

GALLEGO MONTOYA ALFONSO

Liquidador solidario
Nombramiento: 22/05/2009

FERNANDEZ DE LA FUENTE MARIA DE LA PALOMA

Apoderado
Nombramiento: 22/05/2009

MENDEZ RODRIGUEZ MARTA

Apoderado
Nombramiento: 03/04/2009

GALLEGO MONTOYA ALFONSO

Apoderado
Cese: 03/04/2009

DE CORDOBA FONOLLA MANUEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 03/04/2009

GALLEGO MONTOYA ALFONSO

Apoderado
Cese: 28/01/2009

QUINLAN MICHAEL D

Consejero
Nombramiento: 28/01/2009

FLEMING MICHAEL W

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por LABORATORIOS MEDICHIP SL

30/09/2009 Detalles del anuncio (562005)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2009) Año: 2008

22/09/2009 Detalles del anuncio (403997) Datos registrales: T 22233 , F 216, S 8, H M 258584, I/A 36 (10.09.09).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: ANDRES JUSTI IRENE. Consejero: PEREZ MOSQUERA ANTONIO. Presidente: PEREZ MOSQUERA ANTONIO. Consejero: SERRANO SACRISTAN PABLO;FLEMING MICHAEL W.

  • Nombramientos

    LiquiSoli: ANDRES JUSTI IRENE;GALLEGO MONTOYA ALFONSO.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

13/08/2009 Detalles del anuncio (356086) Datos registrales: T 22233 , F 216, S 8, H M 258584, I/A 35 (29.07.09).

  • Sociedad Unipersonal

    MERCK SHARP & DOHME B.V.

22/05/2009 Detalles del anuncio (233575) Datos registrales: T 22233 , F 215, S 8, H M 258584, I/A 34 (11.05.09).

  • Nombramientos

    Apoderado: FERNANDEZ DE LA FUENTE MARIA DE LA PALOMA;MENDEZ RODRIGUEZ MARTA.

03/04/2009 Detalles del anuncio (164839) Datos registrales: T 22233 , F 215, S 8, H M 258584, I/A 33 (20.03.09).

  • Nombramientos

    Apoderado: GALLEGO MONTOYA ALFONSO.

03/04/2009 Detalles del anuncio (164837) Datos registrales: T 22233 , F 215, S 8, H M 258584, I/A 31 (20.03.09).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: DE CORDOBA FONOLLA MANUEL.

03/04/2009 Detalles del anuncio (164838) Datos registrales: T 22233 , F 215, S 8, H M 258584, I/A 32 (20.03.09).

  • Nombramientos

    Apoderado: GALLEGO MONTOYA ALFONSO.

28/01/2009 Detalles del anuncio (46498) Datos registrales: T 22233 , F 214, S 8, H M 258584, I/A 30 (16.01.09).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: QUINLAN MICHAEL D.

  • Nombramientos

    Consejero: FLEMING MICHAEL W.

26/01/2009 Detalles del anuncio (41757) Datos registrales: T 22233 , F 213, S 8, H M 258584, I/A 28 (20.08.08).

  • Fe de erratas

    Se publico por error en la inscripción 28 el nombramiento de Don SERRANO SACRISTAN PABLO como ADMINISTRADOR MANCOMUNADO, siendo lo correcto CONSEJERO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-B-2009-187-28 30/09/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-181-28 22/09/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-153-28 13/08/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-95-28 22/05/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-64-28 03/04/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-64-28 03/04/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-64-28 03/04/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-18-28 28/01/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-16-28 26/01/2009 Madrid Descargar