LABORATORIOS BONIQUET SPARCHIM SL

Cambio de denominación social

CALLE EMPORDA ((POL. INDUSTRIAL CAN BERNADES SUBIRA)), 15
 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona  (08130)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 24/08/2018

BDO AUDITORES SLP

Audit.Indiv.
Nombramiento: 24/08/2018

BDO AUDITORES SLP

Auditor de cuentas consolidadas
Cese: 03/06/2016

CANCER VELASCO JOSEP MANUEL

Consejero
Cese: 03/06/2016

BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR

Consejero
Cese: 03/06/2016

COBO ARAGONESES JOSE LUIS

Secretario no consejero
Cese: 03/06/2016

GONZALEZ VARADE PATRICIA

Vicesecretario no consejero
Cese: 03/06/2016

BOSCH BALADA MARIA NURIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 03/06/2016

BARING CONSEJEROS SL

Consejero
Cese: 03/06/2016

LOPEZ GUERRERO RAUL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 03/06/2016

CAMPOY MORGA KARINA

Consejero
Nombramiento: 03/06/2016

CAMPOY MORGA CLAUDIA

Consejero
Nombramiento: 03/06/2016

PERRAMON FLAQUER VICTOR

Secretario no consejero
Nombramiento: 04/11/2015

BDO AUDITORES SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 04/11/2015

BDO AUDITORES SLP

Auditor de cuentas consolidadas
Cese: 05/08/2014

FABREGAT CLOTET JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 05/08/2014

LOPEZ GUERRERO RAUL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 11/02/2014

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 11/02/2014

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 03/10/2013

CAMPOY MORGA KARINA

Apoderado solidario
Nombramiento: 03/10/2013

GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES

Apoderado solidario
Nombramiento: 28/02/2013

BARING CONSEJEROS SL

Consejero
Nombramiento: 28/02/2013

BERMEJO CUTILLAS JOAN

Consejero
Nombramiento: 28/02/2013

FABREGAT CLOTET JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 15/02/2013

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 15/02/2013

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 11/09/2012

VILARROIG ALEBESQUE JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 24/08/2012

SALDAÑA CARRIERE JORGE

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por LABORATORIOS BONIQUET SPARCHIM SL

08/01/2020 Detalles del anuncio (4065) Datos registrales: T 41697 , F 49, S 8, H B 327893, I/A 30 (30.12.19).

  • Cambio de denominación social

    GRUPO BONIQUET S.L.

24/08/2018 Detalles del anuncio (349581) Datos registrales: T 41697 , F 49, S 8, H B 327893, I/A 29 (16.08.18).

  • Nombramientos

    AUDIT.INDIV.: BDO AUDITORES SLP. AUDT.CTS.CON: BDO AUDITORES SLP.

16/06/2016 Detalles del anuncio (254041) Datos registrales: T 41697 , F 48, S 8, H B 327893, I/A 28 ( 8.06.16).

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5,6,7,8,9,10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

03/06/2016 Detalles del anuncio (236258) Datos registrales: T 41697 , F 48, S 8, H B 327893, I/A 27 (27.05.16).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: CANCER VELASCO JOSEP MANUEL;BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR. SECR.NO CONS: COBO ARAGONESES JOSE LUIS. V-SEC NO CON: GONZALEZ VARADE PATRICIA. REPR.143 RRM: BOSCH BALADA MARIA NURIA. CONSEJERO: BARING CONSEJEROS SL. REPR.143 RRM: LOPEZ GUERRERO RAUL.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: CAMPOY MORGA KARINA;CAMPOY MORGA CLAUDIA. SECR.NO CONS: PERRAMON FLAQUER VICTOR.

01/06/2016 Detalles del anuncio (231546) Datos registrales: T 41697 , F 47, S 8, H B 327893, I/A 26 (24.05.16).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 358.062,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.975.910,00 Euros.

04/11/2015 Detalles del anuncio (444016) Datos registrales: T 41697 , F 46, S 8, H B 327893, I/A 25 (27.10.15).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SLP. AUDT.CTS.CON: BDO AUDITORES SLP.

09/12/2014 Detalles del anuncio (499623) Datos registrales: T 41697 , F 46, S 8, H B 327893, I/A 24 (28.11.14).

  • Modificaciones Estatutarias

    ART.24: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.

05/08/2014 Detalles del anuncio (321014) Datos registrales: T 41697 , F 46, S 8, H B 327893, I/A 23 (28.07.14).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: FABREGAT CLOTET JOSEP.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: LOPEZ GUERRERO RAUL.

11/02/2014 Detalles del anuncio (62253) Datos registrales: T 41697 , F 46, S 8, H B 327893, I/A 22 ( 4.02.14).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. AUDT.CTS.CON: BDO AUDITORES SL.

03/10/2013 Detalles del anuncio (423252) Datos registrales: T 41697 , F 45, S 8, H B 327893, I/A 21 (26.09.13).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: CAMPOY MORGA KARINA;GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 27

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2020-4-08 08/01/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-163-08 24/08/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-114-08 16/06/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-105-08 03/06/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-103-08 01/06/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-211-08 04/11/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-234-08 09/12/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-147-08 05/08/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-28-08 11/02/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-189-08 03/10/2013 Barcelona Descargar