IRE-RE GENOVA SL

Activa

C/ ALCALA 125 - 1º DERECHA (MADRID).
-
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 30/08/2024

HOYA CUBILLAS FRANCISCO BORJA

Administrador mancomunado
Cese: 30/08/2024

SAN JUAN MONJE FERNANDO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 30/08/2024

RODRIGUEZ-MONSALVE ABOGADOS SOCIEDAD LIMITADA PROF

Administrador único
Nombramiento: 30/08/2024

RODRIGUEZ MONSALVE NAVARRO JOSE

Representante
Nombramiento: 27/08/2024

RODRIGUEZ MONSALVE NAVARRO JOSE

Apoderado
Cese: 27/08/2024

GOMEZ DIEZ ISABEL

Apoderado
Cese: 27/08/2024

PELAEZ VARA JULIA

Apoderado
Cese: 27/08/2024

PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO

Apoderado
Cese: 27/08/2024

AYLLON FERNANDEZ MARIA ANGELES

Apoderado
Cese: 27/08/2024

CEACERO ESCOLAR IRENE

Apoderado
Cese: 27/08/2024

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON

Apoderado mancomunado
Cese: 27/08/2024

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON

Apoderado
Cese: 27/08/2024

REY HERNANDEZ DIEGO

Apoderado
Cese: 27/08/2024

PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA

Apoderado
Nombramiento: 27/08/2024

REY HERNANDEZ DIEGO

Apoderado
Nombramiento: 27/08/2024

PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA

Apoderado
Cese: 11/08/2023

MONGE RUIZ ALEJANDRO

Administrador mancomunado
Cese: 07/12/2021

FOY JUSTIN DAMIAN

Apoderado
Nombramiento: 07/12/2021

THORSTEINSDOTTIR SARA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 07/12/2021

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 07/12/2021

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON

Apoderado
Cese: 20/05/2021

GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

SAEZ SERRANO SARA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

MELVIN GAMIR MIA MARIA TERESA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

COSTE FABRICE

Apoderado
Cese: 20/05/2021

GENIAUX MARION

Apoderado
Cese: 20/05/2021

ROFE ANDREW

Apoderado
Cese: 20/05/2021

TAFT ALEXANDER

Apoderado
Cese: 20/05/2021

MURRU ANDREA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

BINGHAM PADDY

Apoderado
Cese: 20/05/2021

SCHMITZ SIMONE

Apoderado
Cese: 20/05/2021

FOY JUSTIN DAMIAN

Apoderado
Cese: 20/05/2021

BROWN HANNAH

Apoderado
Cese: 20/05/2021

KAR SAGARIKA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

SAEZ SERRANO SARA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

PASTRANA GOMEZ ELENA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

MELVIN GARVIN MIA MARIA TERESA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

VALCARCEL SANCHEZ PAULA

Apoderado
Cese: 20/05/2021

ORTEGA SANCHEZ RUBEN

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

COSTE FABRICE

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

GENIAUX MARION

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

KAR SAGARIKA

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

FOY JUSTIN DAMIAN

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

SCHMITZ SIMONE

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

GURRALA SRAVAN KUMAR

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

HASAN SHAIKH ABDUL

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

GOMEZ DIEZ ISABEL

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

PELAEZ VARA JULIA

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

AYLLON FERNANDEZ MARIA ANGELES

Apoderado
Nombramiento: 20/05/2021

CEACERO ESCOLAR IRENE

Apoderado
Cese: 27/01/2020

GOMEZ DIEZ ISABEL

Apoderado
Cese: 27/01/2020

GOMEZ DIEZ ISABEL

Apoderado
Cese: 27/01/2020

GOMEZ DIEZ ISABEL

Apoderado
Nombramiento: 17/04/2019

GOMEZ DIEZ ISABEL

Apoderado
Nombramiento: 17/04/2019

GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA

Apoderado
Nombramiento: 17/04/2019

VALCARCEL SANCHEZ PAULA

Apoderado
Nombramiento: 17/04/2019

ORTEGA SANCHEZ RUBEN

Apoderado
Cese: 17/04/2019

GOMEZ DIEZ ISABEL

Administrador mancomunado
Cese: 17/04/2019

GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA

Administrador mancomunado
Cese: 17/04/2019

SAN JUAN MONJE FERNANDO

Administrador mancomunado
Cese: 17/04/2019

HOYA CUBILLAS FRANCISCO BORJA

Administrador mancomunado
Nombramiento: 17/04/2019

MONGE RUIZ ALEJANDRO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 17/04/2019

HOYA CUBILLAS FRANCISCO BORJA

Administrador mancomunado
Nombramiento: 17/04/2019

SAN JUAN MONJE FERNANDO

Administrador mancomunado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por IRE-RE GENOVA SL

30/08/2024 Detalles del anuncio (377821) Datos registrales: S 8 , H M 647272, I/A 21 (23.08.24).

  • Sociedad Unipersonal

    IBR HOLDCO SL.

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: HOYA CUBILLAS FRANCISCO BORJA;SAN JUAN MONJE FERNANDO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: RODRIGUEZ-MONSALVE ABOGADOS SOCIEDAD LIMITADA PROF. Representan: RODRIGUEZ MONSALVE NAVARRO JOSE.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único.

  • Cambio de domicilio social

    C/ ALCALA 125 - 1º DERECHA (MADRID).

29/08/2024 Detalles del anuncio (376430) Datos registrales: S 8 , H M 647272, I/A 20 (22.08.24).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 300.682,00 Euros. Resultante Suscrito: 296.212,00 Euros.

27/08/2024 Detalles del anuncio (372712) Datos registrales: S 8 , H M 647272, I/A 19 (20.08.24).

  • Nombramientos

    Apoderado: RODRIGUEZ MONSALVE NAVARRO JOSE.

27/08/2024 Detalles del anuncio (372711) Datos registrales: S 8 , H M 647272, I/A 18 (20.08.24).

  • Revocaciones

    Apoderado: GOMEZ DIEZ ISABEL;PELAEZ VARA JULIA;PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO;AYLLON FERNANDEZ MARIA ANGELES;CEACERO ESCOLAR IRENE. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON;REY HERNANDEZ DIEGO;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA.

27/08/2024 Detalles del anuncio (372710) Datos registrales: T 38537 , F 160, S 8, H M 647272, I/A 12 (13.05.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: REY HERNANDEZ DIEGO;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA.

  • Fe de erratas

    Se omitio por error en la inscripción 12ª la publicación del nombramiento como apoderados de PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA y REY HERNANDEZ DIEGO.

29/08/2023 Detalles del anuncio (383136) Datos registrales: T 38537 , F 163, S 8, H M 647272, I/A 17 (22.08.23).

    11/08/2023 Detalles del anuncio (365108) Datos registrales: T 38537 , F 163, S 8, H M 647272, I/A 16 ( 4.08.23).

    • Ceses/Dimisiones

      Adm. Mancom.: MONGE RUIZ ALEJANDRO.

    27/07/2022 Detalles del anuncio (346520) Datos registrales: T 38537 , F 163, S 8, H M 647272, I/A 15 (19.07.22).

    • Cambio de domicilio social

      C/ PINAR 7 1ª (MADRID).

    07/12/2021 Detalles del anuncio (527950) Datos registrales: T 38537 , F 162, S 8, H M 647272, I/A 14 (29.11.21).

    • Revocaciones

      Apoderado: FOY JUSTIN DAMIAN.

    • Nombramientos

      Apo.Manc.: THORSTEINSDOTTIR SARA;RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE RAMON.

    24/05/2021 Detalles del anuncio (247438) Datos registrales: T 38537 , F 161, S 8, H M 647272, I/A 13 (17.05.21).

    • Ampliación de Capital

      Capital: 120.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 596.894,00 Euros.

    Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

    #CVE
    Fecha
    Provincia
    BORME-A-2024-167-28 30/08/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2024-166-28 29/08/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2024-164-28 27/08/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2024-164-28 27/08/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2024-164-28 27/08/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2023-164-28 29/08/2023 Madrid Descargar
    BORME-A-2023-153-28 11/08/2023 Madrid Descargar
    BORME-A-2022-142-28 27/07/2022 Madrid Descargar
    BORME-A-2021-233-28 07/12/2021 Madrid Descargar
    BORME-A-2021-96-28 24/05/2021 Madrid Descargar