IPROTEOS SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 28/07/2020 | LAURENT NGUYEN CONG DUC |
Apoderado solidario |
| Cese: 24/07/2020 | GIRALT LLEDO ERNEST |
Consejero |
| Cese: 24/07/2020 | GIRALT LLEDO ERNEST |
Presidente |
| Cese: 24/07/2020 | TARRAGO CLUA MARIA TERESA |
Consejero |
| Cese: 24/07/2020 | GILABERT MARQUES GUILLERMO |
Secretario no consejero |
| Cese: 24/07/2020 | TARRAGO CLUA MARIA TERESA |
Consejero delegado |
| Cese: 24/07/2020 | ROLF GUNTHER |
Consejero |
| Nombramiento: 24/07/2020 | ACCURE THERAPEUTICS SL |
Administrador único |
| Nombramiento: 24/07/2020 | VENDRELL RIUS MONTSERRAT |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 09/07/2020 | CAIXA CAPITAL RISC SGEIC SA |
Consejero |
| Cese: 09/07/2020 | CIRONI LOPEZ PABLO GABRIEL |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 18/07/2019 | MESA CEJUDO JOSE ANTONIO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 18/07/2019 | CIRONI LOPEZ PABLO GABRIEL |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 29/10/2018 | ROLF GUNTHER |
Consejero |
| Cese: 24/07/2018 | ESTEBAN NIETO CARLOS |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 24/07/2018 | MESA CEJUDO JOSE ANTONIO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 29/01/2018 | CASTA RUIZ ALEXANDRE |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 29/01/2018 | ESTEBAN NIETO CARLOS |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 18/01/2017 | TARRAGO CLUA MARIA TERESA |
Consejero delegado |
| Cese: 30/12/2016 | DIAZ TALAVAN JESUS |
Consejero |
| Nombramiento: 30/12/2016 | CAIXA CAPITAL RISC SGEIC SA |
Consejero |
| Nombramiento: 30/12/2016 | CASTA RUIZ ALEXANDRE |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 03/11/2015 | TARRAGO CLUA MARIA TERESA |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 03/11/2015 | TARRAGO CLUA MARIA TERESA |
Director general |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por IPROTEOS SL
03/02/2021 Detalles del anuncio (51753) Datos registrales: T 47385 , F 191, S 8, H B 412228, I/A 26 (26.01.21).
- Extinción
28/07/2020 Detalles del anuncio (243330) Datos registrales: T 45859 , F 75, S 8, H B 412228, I/A 25 (16.07.20).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: LAURENT NGUYEN CONG DUC.
24/07/2020 Detalles del anuncio (239568) Datos registrales: T 45859 , F 73, S 8, H B 412228, I/A 24 (16.07.20).
- Revocaciones
CONSEJERO: GIRALT LLEDO ERNEST. PRESIDENTE: GIRALT LLEDO ERNEST. CONSEJERO: TARRAGO CLUA MARIA TERESA. SECR.NO CONS: GILABERT MARQUES GUILLERMO. CONS. DELEG.: TARRAGO CLUA MARIA TERESA. CONSEJERO: ROLF GUNTHER.
- Nombramientos
ADM.UNICO: ACCURE THERAPEUTICS SL. REPR.143 RRM: VENDRELL RIUS MONTSERRAT.
- Otros Conceptos
DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: ACCURE THERAPEUTICS S.L.
09/07/2020 Detalles del anuncio (213320) Datos registrales: T 45859 , F 73, S 8, H B 412228, I/A 23 ( 1.07.20).
- Revocaciones
CONSEJERO: CAIXA CAPITAL RISC SGEIC SA. REPR.143 RRM: CIRONI LOPEZ PABLO GABRIEL.
27/03/2020 Detalles del anuncio (133686) Datos registrales: T 45859 , F 71, S 8, H B 412228, I/A 22 (18.03.20).
- Ampliación de Capital
Capital: 1.312,29 Euros. Resultante Suscrito: 11.887,56 Euros.
11/03/2020 Detalles del anuncio (110846) Datos registrales: T 45859 , F 70, S 8, H B 412228, I/A 21 ( 3.03.20).
- Cambio de domicilio social
PS JOAN DE BORBO Num.99 P.2 (BARCELONA).
18/07/2019 Detalles del anuncio (309817) Datos registrales: T 45859 , F 70, S 8, H B 412228, I/A 20 (11.07.19).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: MESA CEJUDO JOSE ANTONIO.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: CIRONI LOPEZ PABLO GABRIEL.
29/10/2018 Detalles del anuncio (430507) Datos registrales: T 45859 , F 69, S 8, H B 412228, I/A 19 (19.10.18).
- Nombramientos
CONSEJERO: ROLF GUNTHER.
- Ampliación de Capital
Capital: 501,75 Euros. Resultante Suscrito: 10.575,27 Euros.
24/07/2018 Detalles del anuncio (305268) Datos registrales: T 45859 , F 69, S 8, H B 412228, I/A 18 (17.07.18).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: ESTEBAN NIETO CARLOS.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: MESA CEJUDO JOSE ANTONIO.
29/01/2018 Detalles del anuncio (43754) Datos registrales: T 45859 , F 69, S 8, H B 412228, I/A 17 (22.01.18).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: CASTA RUIZ ALEXANDRE.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: ESTEBAN NIETO CARLOS.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 26
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2021-22-08 | 03/02/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-144-08 | 28/07/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-142-08 | 24/07/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-131-08 | 09/07/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-61-08 | 27/03/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-49-08 | 11/03/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-136-08 | 18/07/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-208-08 | 29/10/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-141-08 | 24/07/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-20-08 | 29/01/2018 | Barcelona | Descargar |