ICLAVES SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 15/01/2025 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Administrador único |
| Nombramiento: 15/01/2025 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Administrador |
| Cese: 23/07/2021 | PIÑAR PINEDO JOSE MARIA |
Administrador único |
| Nombramiento: 23/07/2021 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Administrador único |
| Cese: 25/03/2019 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Consejero |
| Cese: 25/03/2019 | RIVERA PASTOR RAFAEL |
Consejero |
| Cese: 25/03/2019 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Consejero |
| Cese: 25/03/2019 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Presidente |
| Cese: 25/03/2019 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Secretario |
| Nombramiento: 25/03/2019 | PIÑAR PINEDO JOSE MARIA |
Administrador único |
| Cese: 01/02/2018 | COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE |
Consejero |
| Cese: 01/02/2018 | COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE |
Apoderado |
| Cese: 02/03/2016 | RIVERA PASTOR RAFAEL |
Administrador único |
| Nombramiento: 02/03/2016 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Consejero |
| Nombramiento: 02/03/2016 | RIVERA PASTOR RAFAEL |
Consejero |
| Nombramiento: 02/03/2016 | COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 02/03/2016 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Consejero |
| Nombramiento: 02/03/2016 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Presidente |
| Nombramiento: 02/03/2016 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Secretario |
| Nombramiento: 02/03/2016 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 02/03/2016 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Apoderado solidario |
| Cese: 21/10/2014 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Apoderado solidario |
| Cese: 21/10/2014 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Apoderado solidario |
| Cese: 21/10/2014 | COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 21/10/2014 | COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE |
Apoderado |
| Nombramiento: 21/10/2014 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Apoderado |
| Nombramiento: 21/10/2014 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Apoderado |
| Cese: 04/09/2013 | RIVERA PASTOR RAFAEL |
Consejero |
| Cese: 04/09/2013 | ARTOLA MENENDEZ MIGUEL |
Consejero |
| Cese: 04/09/2013 | RIVERA PASTOR RAFAEL |
Secretario |
| Nombramiento: 04/09/2013 | RIVERA PASTOR RAFAEL |
Administrador único |
| Nombramiento: 04/09/2013 | COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 04/09/2013 | VILLAR GARCIA JUAN PABLO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 04/09/2013 | TARIN QUIROS CARLOTA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 04/09/2013 | COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE |
Apoderado solidario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ICLAVES SL
15/01/2025 Detalles del anuncio (16821) Datos registrales: S 8 , H M 474862, I/A 23 ( 8.01.25).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.
- Nombramientos
Administrad: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.
- Disolución
Voluntaria.
- Extinción
23/07/2021 Detalles del anuncio (353178) Datos registrales: T 28019 , F 206, S 8, H M 474862, I/A 22 (16.07.21).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: PIÑAR PINEDO JOSE MARIA.
- Nombramientos
Adm. Unico: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.
- Cambio de domicilio social
C/ ROSALIA DE CASTRO 35 (VALDEMORO).
25/03/2019 Detalles del anuncio (134368) Datos registrales: T 28019 , F 205, S 8, H M 474862, I/A 21 (18.03.19).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: TARIN QUIROS CARLOTA;RIVERA PASTOR RAFAEL;VILLAR GARCIA JUAN PABLO. Presidente: TARIN QUIROS CARLOTA. Secretario: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.
- Nombramientos
Adm. Unico: PIÑAR PINEDO JOSE MARIA.
- Otros Conceptos
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
24/05/2018 Detalles del anuncio (220337) Datos registrales: T 28019 , F 203, S 8, H M 474862, I/A 20 (16.05.18).
- Ampliación de Capital
Capital: 2.982,24 Euros. Resultante Suscrito: 6.934,24 Euros.
- Cambio de domicilio social
C/ MIGUEL YUSTE 12 (MADRID).
- Cambio de objeto social
La consultoría de organización, gestión, dirección y administración en el ámbito jurídico, tecnológico, económico, financiero, de gestión, marketing, y de estudio de mercados, así como la prestación directa de servicios relacionado con esa actividad, tanto para el sector público como privado....
- Fusión por Absorción
Sociedades absorbidas: QUANTICAE DATA ANALYTICS SL.
01/02/2018 Detalles del anuncio (52067) Datos registrales: T 28019 , F 203, S 8, H M 474862, I/A 19 (25.01.18).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE.
- Revocaciones
Apoderado: COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE.
02/03/2016 Detalles del anuncio (95839) Datos registrales: T 28019 , F 201, S 8, H M 474862, I/A 17 (23.02.16).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: RIVERA PASTOR RAFAEL.
- Nombramientos
Consejero: TARIN QUIROS CARLOTA;RIVERA PASTOR RAFAEL;COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE;VILLAR GARCIA JUAN PABLO. Presidente: TARIN QUIROS CARLOTA. Secretario: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.
- Otros Conceptos
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.
02/03/2016 Detalles del anuncio (95840) Datos registrales: T 28019 , F 201, S 8, H M 474862, I/A 18 (23.02.16).
- Nombramientos
Apo.Sol.: TARIN QUIROS CARLOTA;VILLAR GARCIA JUAN PABLO.
21/10/2014 Detalles del anuncio (420870) Datos registrales: T 26350 , F 206, S 8, H M 474862, I/A 16 (10.10.14).
- Revocaciones
Apo.Sol.: VILLAR GARCIA JUAN PABLO;TARIN QUIROS CARLOTA;COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE.
- Nombramientos
Apoderado: COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE;VILLAR GARCIA JUAN PABLO;TARIN QUIROS CARLOTA.
23/04/2014 Detalles del anuncio (176370) Datos registrales: T 26350 , F 205, S 8, H M 474862, I/A 15 (11.04.14).
- Ampliación de Capital
Capital: 942,40 Euros. Resultante Suscrito: 3.952,00 Euros.
04/09/2013 Detalles del anuncio (387613) Datos registrales: T 26350 , F 201, S 8, H M 474862, I/A 12 (23.08.13).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: RIVERA PASTOR RAFAEL;ARTOLA MENENDEZ MIGUEL. Secretario: RIVERA PASTOR RAFAEL.
- Nombramientos
Adm. Unico: RIVERA PASTOR RAFAEL.
- Modificaciones Estatutarias
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
- Cambio de domicilio social
C/ SANTA ENGRACIA 108 - 6º INTERIOR DERECHA (MADRID).
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 24
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2025-9-28 | 15/01/2025 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2021-140-28 | 23/07/2021 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2019-58-28 | 25/03/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2018-98-28 | 24/05/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2018-23-28 | 01/02/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-42-28 | 02/03/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-42-28 | 02/03/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-201-28 | 21/10/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-77-28 | 23/04/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-168-28 | 04/09/2013 | Madrid | Descargar |