ICLAVES SL

Extinta

C/ ROSALIA DE CASTRO 35 (VALDEMORO).
 Valdemoro, Madrid  (28340)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 15/01/2025

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Administrador único
Nombramiento: 15/01/2025

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Administrador
Cese: 23/07/2021

PIÑAR PINEDO JOSE MARIA

Administrador único
Nombramiento: 23/07/2021

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Administrador único
Cese: 25/03/2019

TARIN QUIROS CARLOTA

Consejero
Cese: 25/03/2019

RIVERA PASTOR RAFAEL

Consejero
Cese: 25/03/2019

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Consejero
Cese: 25/03/2019

TARIN QUIROS CARLOTA

Presidente
Cese: 25/03/2019

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Secretario
Nombramiento: 25/03/2019

PIÑAR PINEDO JOSE MARIA

Administrador único
Cese: 01/02/2018

COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE

Consejero
Cese: 01/02/2018

COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE

Apoderado
Cese: 02/03/2016

RIVERA PASTOR RAFAEL

Administrador único
Nombramiento: 02/03/2016

TARIN QUIROS CARLOTA

Consejero
Nombramiento: 02/03/2016

RIVERA PASTOR RAFAEL

Consejero
Nombramiento: 02/03/2016

COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE

Consejero
Nombramiento: 02/03/2016

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Consejero
Nombramiento: 02/03/2016

TARIN QUIROS CARLOTA

Presidente
Nombramiento: 02/03/2016

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Secretario
Nombramiento: 02/03/2016

TARIN QUIROS CARLOTA

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/03/2016

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Apoderado solidario
Cese: 21/10/2014

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Apoderado solidario
Cese: 21/10/2014

TARIN QUIROS CARLOTA

Apoderado solidario
Cese: 21/10/2014

COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 21/10/2014

COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE

Apoderado
Nombramiento: 21/10/2014

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Apoderado
Nombramiento: 21/10/2014

TARIN QUIROS CARLOTA

Apoderado
Cese: 04/09/2013

RIVERA PASTOR RAFAEL

Consejero
Cese: 04/09/2013

ARTOLA MENENDEZ MIGUEL

Consejero
Cese: 04/09/2013

RIVERA PASTOR RAFAEL

Secretario
Nombramiento: 04/09/2013

RIVERA PASTOR RAFAEL

Administrador único
Nombramiento: 04/09/2013

COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/09/2013

VILLAR GARCIA JUAN PABLO

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/09/2013

TARIN QUIROS CARLOTA

Apoderado solidario
Nombramiento: 04/09/2013

COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE

Apoderado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ICLAVES SL

15/01/2025 Detalles del anuncio (16821) Datos registrales: S 8 , H M 474862, I/A 23 ( 8.01.25).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.

  • Nombramientos

    Administrad: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

23/07/2021 Detalles del anuncio (353178) Datos registrales: T 28019 , F 206, S 8, H M 474862, I/A 22 (16.07.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: PIÑAR PINEDO JOSE MARIA.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.

  • Cambio de domicilio social

    C/ ROSALIA DE CASTRO 35 (VALDEMORO).

25/03/2019 Detalles del anuncio (134368) Datos registrales: T 28019 , F 205, S 8, H M 474862, I/A 21 (18.03.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: TARIN QUIROS CARLOTA;RIVERA PASTOR RAFAEL;VILLAR GARCIA JUAN PABLO. Presidente: TARIN QUIROS CARLOTA. Secretario: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: PIÑAR PINEDO JOSE MARIA.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

24/05/2018 Detalles del anuncio (220337) Datos registrales: T 28019 , F 203, S 8, H M 474862, I/A 20 (16.05.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 2.982,24 Euros. Resultante Suscrito: 6.934,24 Euros.

  • Cambio de domicilio social

    C/ MIGUEL YUSTE 12 (MADRID).

  • Cambio de objeto social

    La consultoría de organización, gestión, dirección y administración en el ámbito jurídico, tecnológico, económico, financiero, de gestión, marketing, y de estudio de mercados, así como la prestación directa de servicios relacionado con esa actividad, tanto para el sector público como privado....

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: QUANTICAE DATA ANALYTICS SL.

01/02/2018 Detalles del anuncio (52067) Datos registrales: T 28019 , F 203, S 8, H M 474862, I/A 19 (25.01.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE.

  • Revocaciones

    Apoderado: COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE.

02/03/2016 Detalles del anuncio (95839) Datos registrales: T 28019 , F 201, S 8, H M 474862, I/A 17 (23.02.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: RIVERA PASTOR RAFAEL.

  • Nombramientos

    Consejero: TARIN QUIROS CARLOTA;RIVERA PASTOR RAFAEL;COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE;VILLAR GARCIA JUAN PABLO. Presidente: TARIN QUIROS CARLOTA. Secretario: VILLAR GARCIA JUAN PABLO.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.

02/03/2016 Detalles del anuncio (95840) Datos registrales: T 28019 , F 201, S 8, H M 474862, I/A 18 (23.02.16).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: TARIN QUIROS CARLOTA;VILLAR GARCIA JUAN PABLO.

21/10/2014 Detalles del anuncio (420870) Datos registrales: T 26350 , F 206, S 8, H M 474862, I/A 16 (10.10.14).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: VILLAR GARCIA JUAN PABLO;TARIN QUIROS CARLOTA;COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE.

  • Nombramientos

    Apoderado: COLOMBANO GONZALEZ ALFREDO JOSE;VILLAR GARCIA JUAN PABLO;TARIN QUIROS CARLOTA.

23/04/2014 Detalles del anuncio (176370) Datos registrales: T 26350 , F 205, S 8, H M 474862, I/A 15 (11.04.14).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 942,40 Euros. Resultante Suscrito: 3.952,00 Euros.

04/09/2013 Detalles del anuncio (387613) Datos registrales: T 26350 , F 201, S 8, H M 474862, I/A 12 (23.08.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: RIVERA PASTOR RAFAEL;ARTOLA MENENDEZ MIGUEL. Secretario: RIVERA PASTOR RAFAEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: RIVERA PASTOR RAFAEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

  • Cambio de domicilio social

    C/ SANTA ENGRACIA 108 - 6º INTERIOR DERECHA (MADRID).

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 24

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2025-9-28 15/01/2025 Madrid Descargar
BORME-A-2021-140-28 23/07/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2019-58-28 25/03/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-98-28 24/05/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-23-28 01/02/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2016-42-28 02/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-42-28 02/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-201-28 21/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-77-28 23/04/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-168-28 04/09/2013 Madrid Descargar