GRUSAFYC SL

Cambio de denominación social

C/ CONCEJO DE TEVERGA, NUMERO 9 LOCAL E (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 08/05/2015

GONZALEZ FERNANDEZ PABLO

Apoderado
Cese: 08/05/2015

GONZALEZ CHALA PABLO

Apoderado
Cese: 08/05/2015

FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GRUSAFYC SL

27/12/2016 Detalles del anuncio (524500) Datos registrales: T 24577 , F 139, S 8, H M 442336, I/A 9 (16.12.16).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-.

  • Cambio de denominación social

    CLIMATEC INSTALACIONES HIDRAULICAS SL.

08/03/2016 Detalles del anuncio (108119) Datos registrales: T 24577 , F 138, S 8, H M 442336, I/A 8 (29.02.16).

  • Cambio de domicilio social

    C/ CONCEJO DE TEVERGA, NUMERO 9 LOCAL E (MADRID).

08/05/2015 Detalles del anuncio (188770) Datos registrales: T 24577 , F 138, S 8, H M 442336, I/A 5 (27.04.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PABLO.

08/05/2015 Detalles del anuncio (188771) Datos registrales: T 24577 , F 138, S 8, H M 442336, I/A 6 (27.04.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: GONZALEZ CHALA PABLO.

08/05/2015 Detalles del anuncio (188772) Datos registrales: T 24577 , F 138, S 8, H M 442336, I/A 7 (27.04.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 5

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2016-244-28 27/12/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-46-28 08/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-86-28 08/05/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-86-28 08/05/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-86-28 08/05/2015 Madrid Descargar