GRUP LASEM GESTIO SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
Fecha
|
Nombre
|
|
---|---|---|
Cese: 20/01/2021 | VILARO TEXIDO DAVID JUAN |
Apoderado |
Cese: 20/01/2021 | VILARO TEIXIDO DAVID |
Apoderado |
Nombramiento: 20/01/2021 | VILARO TEIXIDO DAVID |
Apoderado solidario |
Cese: 18/02/2020 | BETRIU PI JOSE |
Consejero |
Cese: 18/02/2020 | MARTI PELLISE JOSE |
Consejero |
Cese: 18/02/2020 | MARTI PELLISE JOSE |
Presidente |
Cese: 18/02/2020 | BETRIU PI JOSE |
Consejero delegado |
Cese: 18/02/2020 | AMAT BADRINAS XAVIER |
Secretario no consejero |
Cese: 18/02/2020 | LOPEZ CAVIA MANEL |
Consejero |
Nombramiento: 18/02/2020 | MARTI PELLISE JOSEP |
Administrador único |
Cese: 21/02/2017 | MALLOL CARRERAS EFREM |
Consejero |
Nombramiento: 21/02/2017 | LOPEZ CAVIA MANEL |
Consejero |
Nombramiento: 10/02/2016 | BDO AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
Nombramiento: 22/05/2015 | LOPEZ CAVIA MANEL |
Apoderado solidario |
Nombramiento: 09/12/2014 | BDO AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
Nombramiento: 03/11/2014 | BDO AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
Nombramiento: 04/12/2012 | BDO AUDITORES SL |
Auditor de cuentas |
Nombramiento: 04/12/2012 | BDO AUDITORES SL |
Auditor de cuentas consolidadas |
Cese: 15/06/2012 | PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL |
Consejero |
Cese: 15/06/2012 | PARTILONIA ADMINISTRACION SL |
Consejero |
Cese: 15/06/2012 | DELGADO LUQUE BRUNO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Cese: 15/06/2012 | PRAT GONZALEZ PEDRO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
Nombramiento: 30/08/2011 | VILARO TEIXIDO DAVID |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GRUP LASEM GESTIO SL
20/01/2021 Detalles del anuncio (25584) Datos registrales: T 44807 , F 12, S 8, H B 49101, I/A 41 (12.01.21).
- Revocaciones
APODERADO: VILARO TEXIDO DAVID JUAN;VILARO TEIXIDO DAVID.
- Nombramientos
APODERAD.SOL: VILARO TEIXIDO DAVID.
18/02/2020 Detalles del anuncio (73828) Datos registrales: T 44807 , F 12, S 8, H B 49101, I/A 40 ( 7.02.20).
- Revocaciones
CONSEJERO: BETRIU PI JOSE;MARTI PELLISE JOSE. PRESIDENTE: MARTI PELLISE JOSE. CONS. DELEG.: BETRIU PI JOSE. SECR.NO CONS: AMAT BADRINAS XAVIER. CONSEJERO: LOPEZ CAVIA MANEL.
- Nombramientos
ADM.UNICO: MARTI PELLISE JOSEP.
- Otros Conceptos
DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DON JOSEP MARTI PELLISE.
21/02/2017 Detalles del anuncio (83327) Datos registrales: T 44807 , F 11, S 8, H B 49101, I/A 39 (10.02.17).
- Revocaciones
CONSEJERO: MALLOL CARRERAS EFREM.
- Nombramientos
CONSEJERO: LOPEZ CAVIA MANEL.
10/02/2016 Detalles del anuncio (59126) Datos registrales: T 44807 , F 11, S 8, H B 49101, I/A 38 ( 3.02.16).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL.
22/05/2015 Detalles del anuncio (205877) Datos registrales: T 36027 , F 180, S 8, H B 49101, I/A 37 (13.05.15).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: LOPEZ CAVIA MANEL.
11/03/2015 Detalles del anuncio (105000) Datos registrales: T 36027 , F 180, S 8, H B 49101, I/A 36 ( 4.03.15).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 836.027,90 Euros. Resultante Suscrito: 1.178.500,00 Euros.
- Ampliación de Capital
Capital: 836.027,90 Euros. Resultante Suscrito: 2.014.527,90 Euros.
09/12/2014 Detalles del anuncio (499984) Datos registrales: T 36027 , F 180, S 8, H B 49101, I/A 35 ( 1.12.14).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL.
03/11/2014 Detalles del anuncio (441414) Datos registrales: T 36027 , F 179, S 8, H B 49101, I/A 34 (24.10.14).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL.
04/12/2012 Detalles del anuncio (499367) Datos registrales: T 36027 , F 179, S 8, H B 49101, I/A 33 (23.11.12).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. AUDT.CTS.CON: BDO AUDITORES SL.
15/06/2012 Detalles del anuncio (252611) Datos registrales: T 36027 , F 179, S 8, H B 49101, I/A 32 ( 6.06.12).
- Revocaciones
CONSEJERO: PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL;PARTILONIA ADMINISTRACION SL. REPR.143 RRM: DELGADO LUQUE BRUNO;PRAT GONZALEZ PEDRO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
---|---|---|---|
BORME-A-2021-12-08 | 20/01/2021 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2020-33-08 | 18/02/2020 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2017-36-08 | 21/02/2017 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2016-27-08 | 10/02/2016 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2015-95-08 | 22/05/2015 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2015-48-08 | 11/03/2015 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-234-08 | 09/12/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2014-210-08 | 03/11/2014 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2012-232-08 | 04/12/2012 | Barcelona | Descargar |
BORME-A-2012-113-08 | 15/06/2012 | Barcelona | Descargar |