GRUP LASEM GESTIO SL

Activa

AVENIDA DE INDUSTRIA (- PG IND PLA CAMI), 7
 Castellgalí, Barcelona  (08297)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 20/01/2021

VILARO TEXIDO DAVID JUAN

Apoderado
Cese: 20/01/2021

VILARO TEIXIDO DAVID

Apoderado
Nombramiento: 20/01/2021

VILARO TEIXIDO DAVID

Apoderado solidario
Cese: 18/02/2020

BETRIU PI JOSE

Consejero
Cese: 18/02/2020

MARTI PELLISE JOSE

Consejero
Cese: 18/02/2020

MARTI PELLISE JOSE

Presidente
Cese: 18/02/2020

BETRIU PI JOSE

Consejero delegado
Cese: 18/02/2020

AMAT BADRINAS XAVIER

Secretario no consejero
Cese: 18/02/2020

LOPEZ CAVIA MANEL

Consejero
Nombramiento: 18/02/2020

MARTI PELLISE JOSEP

Administrador único
Cese: 21/02/2017

MALLOL CARRERAS EFREM

Consejero
Nombramiento: 21/02/2017

LOPEZ CAVIA MANEL

Consejero
Nombramiento: 10/02/2016

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 22/05/2015

LOPEZ CAVIA MANEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/12/2014

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 03/11/2014

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 04/12/2012

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas
Nombramiento: 04/12/2012

BDO AUDITORES SL

Auditor de cuentas consolidadas
Cese: 15/06/2012

PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL

Consejero
Cese: 15/06/2012

PARTILONIA ADMINISTRACION SL

Consejero
Cese: 15/06/2012

DELGADO LUQUE BRUNO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 15/06/2012

PRAT GONZALEZ PEDRO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 30/08/2011

VILARO TEIXIDO DAVID

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GRUP LASEM GESTIO SL

20/01/2021 Detalles del anuncio (25584) Datos registrales: T 44807 , F 12, S 8, H B 49101, I/A 41 (12.01.21).

  • Revocaciones

    APODERADO: VILARO TEXIDO DAVID JUAN;VILARO TEIXIDO DAVID.

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: VILARO TEIXIDO DAVID.

18/02/2020 Detalles del anuncio (73828) Datos registrales: T 44807 , F 12, S 8, H B 49101, I/A 40 ( 7.02.20).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: BETRIU PI JOSE;MARTI PELLISE JOSE. PRESIDENTE: MARTI PELLISE JOSE. CONS. DELEG.: BETRIU PI JOSE. SECR.NO CONS: AMAT BADRINAS XAVIER. CONSEJERO: LOPEZ CAVIA MANEL.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: MARTI PELLISE JOSEP.

  • Otros Conceptos

    DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DON JOSEP MARTI PELLISE.

21/02/2017 Detalles del anuncio (83327) Datos registrales: T 44807 , F 11, S 8, H B 49101, I/A 39 (10.02.17).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: MALLOL CARRERAS EFREM.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: LOPEZ CAVIA MANEL.

10/02/2016 Detalles del anuncio (59126) Datos registrales: T 44807 , F 11, S 8, H B 49101, I/A 38 ( 3.02.16).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL.

22/05/2015 Detalles del anuncio (205877) Datos registrales: T 36027 , F 180, S 8, H B 49101, I/A 37 (13.05.15).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: LOPEZ CAVIA MANEL.

11/03/2015 Detalles del anuncio (105000) Datos registrales: T 36027 , F 180, S 8, H B 49101, I/A 36 ( 4.03.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 836.027,90 Euros. Resultante Suscrito: 1.178.500,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 836.027,90 Euros. Resultante Suscrito: 2.014.527,90 Euros.

09/12/2014 Detalles del anuncio (499984) Datos registrales: T 36027 , F 180, S 8, H B 49101, I/A 35 ( 1.12.14).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL.

03/11/2014 Detalles del anuncio (441414) Datos registrales: T 36027 , F 179, S 8, H B 49101, I/A 34 (24.10.14).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL.

04/12/2012 Detalles del anuncio (499367) Datos registrales: T 36027 , F 179, S 8, H B 49101, I/A 33 (23.11.12).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. AUDT.CTS.CON: BDO AUDITORES SL.

15/06/2012 Detalles del anuncio (252611) Datos registrales: T 36027 , F 179, S 8, H B 49101, I/A 32 ( 6.06.12).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL;PARTILONIA ADMINISTRACION SL. REPR.143 RRM: DELGADO LUQUE BRUNO;PRAT GONZALEZ PEDRO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-12-08 20/01/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-33-08 18/02/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-36-08 21/02/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-27-08 10/02/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-95-08 22/05/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-48-08 11/03/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-234-08 09/12/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-210-08 03/11/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-232-08 04/12/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-113-08 15/06/2012 Barcelona Descargar