GLEVA CELLARS SA

Extinta

LG CAN CODORNIU,AV JAUME CODORNIU,S/N (SANT SADURNI DANOIA).
-
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 14/05/2021

BARON CERVELLO CHANTAL

Apoderado solidario
Nombramiento: 14/05/2021

LOPEZ MONZO TERESA

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/01/2021

KAREL JULIEN MARC DANES

Apoderado solidario
Cese: 29/12/2020

RAVENTOS BASAGOITI RAMON

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 29/12/2020

FUSTER MERINO SERGIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 03/08/2020

PKF AUDIEC SAP

Auditor de cuentas
Cese: 21/03/2019

RAVENTOS SAENZ RAMON

Consejero
Cese: 21/03/2019

RAVENTOS BASAGOITI RAMON

Consejero
Cese: 21/03/2019

DIEZ TORCA IGNACIO

Consejero
Cese: 21/03/2019

RAVENTOS SAENZ RAMON

Presidente
Cese: 21/03/2019

RAVENTOS SAENZ RAMON

Consejero delegado solidario
Cese: 21/03/2019

RAVENTOS BASAGOITI RAMON

Consejero delegado solidario
Cese: 21/03/2019

MATIAS BELLIDO MANUEL

Consejero
Cese: 21/03/2019

MATIAS BELLIDO MANUEL

Secretario
Nombramiento: 21/03/2019

UNIDECO SOCIEDAD ANONIMA

Administrador único
Nombramiento: 21/03/2019

MARINE SALUDES JAIME

Apoderado
Nombramiento: 21/03/2019

SERRA VILA MONTSERRAT

Apoderado
Nombramiento: 21/03/2019

GALINDO BLANCH ANDRES

Apoderado
Nombramiento: 21/03/2019

PINILLA NAVARRO DIEGO

Apoderado
Nombramiento: 06/09/2018

PKF AUDIEC SOCIEDAD ANONIMA PROFESIONAL

Auditor
Cese: 30/12/2016

VILLAR FERRER JOSE LUIS

Consejero
Cese: 30/12/2016

VILLAR FERRER JOSE LUIS

Secretario
Nombramiento: 30/12/2016

MATIAS BELLIDO MANUEL

Consejero
Nombramiento: 30/12/2016

MATIAS BELLIDO MANUEL

Secretario
Cese: 21/04/2016

RAVENTOS BASAGOITI RAMON

Administrador solidario
Cese: 21/04/2016

BASAGOITI GARCIA TUÑON BELEN

Administrador solidario
Cese: 21/04/2016

RAVENTOS SAENZ RAMON

Administrador solidario
Nombramiento: 21/04/2016

RAVENTOS SAENZ RAMON

Consejero
Nombramiento: 21/04/2016

RAVENTOS BASAGOITI RAMON

Consejero
Nombramiento: 21/04/2016

VILLAR FERRER JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 21/04/2016

RAVENTOS SAENZ RAMON

Presidente
Nombramiento: 21/04/2016

VILLAR FERRER JOSE LUIS

Secretario
Nombramiento: 21/04/2016

PKF AUDIEC SOCIEDAD ANONIMA PROFESIONAL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GLEVA CELLARS SA

18/04/2022 Detalles del anuncio (170739) Datos registrales: T 46935 , F 129, S 8, H B 331105, I/A 29 ( 7.04.22).

  • Extinción

14/05/2021 Detalles del anuncio (226365) Datos registrales: T 46935 , F 129, S 8, H B 331105, I/A 28 ( 6.05.21).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: BARON CERVELLO CHANTAL.

14/05/2021 Detalles del anuncio (226358) Datos registrales: T 46935 , F 128, S 8, H B 331105, I/A 27 ( 6.05.21).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: LOPEZ MONZO TERESA.

22/01/2021 Detalles del anuncio (30415) Datos registrales: T 46935 , F 126, S 8, H B 331105, I/A 26 (14.01.21).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: KAREL JULIEN MARC DANES.

29/12/2020 Detalles del anuncio (464263) Datos registrales: T 46935 , F 125, S 8, H B 331105, I/A 25 (18.12.20).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: RAVENTOS BASAGOITI RAMON.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: FUSTER MERINO SERGIO.

03/08/2020 Detalles del anuncio (250770) Datos registrales: T 46935 , F 125, S 8, H B 331105, I/A 24 (24.07.20).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: PKF AUDIEC SAP.

15/06/2020 Detalles del anuncio (180988) Datos registrales: T 46935 , F 121, S 8, H B 331105, I/A 23 ( 8.06.20).

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: BODEGUES SIGNAT SL. CONSTANTINO SABADO OLIVER SA.

09/06/2020 Detalles del anuncio (174891) Datos registrales: T 46935 , F 120, S 8, H B 331105, I/A 22 ( 2.06.20).

  • Otros Conceptos

    CANCELACION DE GARANTIAS DE LA EMISION DE OBLIGACIONES.

18/07/2019 Detalles del anuncio (309637) Datos registrales: T 46935 , F 119, S 8, H B 331105, I/A 20 ( 9.07.19).

  • Modificaciones Estatutarias

    ART.33 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE JULIO Y FINALIZANDO EL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO.

  • Cambio de domicilio social

    LG CAN CODORNIU,AV JAUME CODORNIU,S/N (SANT SADURNI DANOIA).

18/07/2019 Detalles del anuncio (309639) Datos registrales: T 46935 , F 120, S 8, H B 331105, I/A 21 ( 9.07.19).

  • Otros Conceptos

    DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO, SIENDO EL NUEVO ACCIONISTA UNICO: UNIDECO S.A.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 25

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-73-08 18/04/2022 Barcelona Descargar
BORME-A-2021-90-08 14/05/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2021-90-08 14/05/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2021-14-08 22/01/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-248-08 29/12/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-148-08 03/08/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-113-08 15/06/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-109-08 09/06/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-136-08 18/07/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-136-08 18/07/2019 Barcelona Descargar