GLEVA CELLARS SA
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 14/05/2021 | BARON CERVELLO CHANTAL |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 14/05/2021 | LOPEZ MONZO TERESA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 22/01/2021 | KAREL JULIEN MARC DANES |
Apoderado solidario |
| Cese: 29/12/2020 | RAVENTOS BASAGOITI RAMON |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 29/12/2020 | FUSTER MERINO SERGIO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Nombramiento: 03/08/2020 | PKF AUDIEC SAP |
Auditor de cuentas |
| Cese: 21/03/2019 | RAVENTOS SAENZ RAMON |
Consejero |
| Cese: 21/03/2019 | RAVENTOS BASAGOITI RAMON |
Consejero |
| Cese: 21/03/2019 | DIEZ TORCA IGNACIO |
Consejero |
| Cese: 21/03/2019 | RAVENTOS SAENZ RAMON |
Presidente |
| Cese: 21/03/2019 | RAVENTOS SAENZ RAMON |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 21/03/2019 | RAVENTOS BASAGOITI RAMON |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 21/03/2019 | MATIAS BELLIDO MANUEL |
Consejero |
| Cese: 21/03/2019 | MATIAS BELLIDO MANUEL |
Secretario |
| Nombramiento: 21/03/2019 | UNIDECO SOCIEDAD ANONIMA |
Administrador único |
| Nombramiento: 21/03/2019 | MARINE SALUDES JAIME |
Apoderado |
| Nombramiento: 21/03/2019 | SERRA VILA MONTSERRAT |
Apoderado |
| Nombramiento: 21/03/2019 | GALINDO BLANCH ANDRES |
Apoderado |
| Nombramiento: 21/03/2019 | PINILLA NAVARRO DIEGO |
Apoderado |
| Nombramiento: 06/09/2018 | PKF AUDIEC SOCIEDAD ANONIMA PROFESIONAL |
Auditor |
| Cese: 30/12/2016 | VILLAR FERRER JOSE LUIS |
Consejero |
| Cese: 30/12/2016 | VILLAR FERRER JOSE LUIS |
Secretario |
| Nombramiento: 30/12/2016 | MATIAS BELLIDO MANUEL |
Consejero |
| Nombramiento: 30/12/2016 | MATIAS BELLIDO MANUEL |
Secretario |
| Cese: 21/04/2016 | RAVENTOS BASAGOITI RAMON |
Administrador solidario |
| Cese: 21/04/2016 | BASAGOITI GARCIA TUÑON BELEN |
Administrador solidario |
| Cese: 21/04/2016 | RAVENTOS SAENZ RAMON |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 21/04/2016 | RAVENTOS SAENZ RAMON |
Consejero |
| Nombramiento: 21/04/2016 | RAVENTOS BASAGOITI RAMON |
Consejero |
| Nombramiento: 21/04/2016 | VILLAR FERRER JOSE LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 21/04/2016 | RAVENTOS SAENZ RAMON |
Presidente |
| Nombramiento: 21/04/2016 | VILLAR FERRER JOSE LUIS |
Secretario |
| Nombramiento: 21/04/2016 | PKF AUDIEC SOCIEDAD ANONIMA PROFESIONAL |
Auditor |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GLEVA CELLARS SA
18/04/2022 Detalles del anuncio (170739) Datos registrales: T 46935 , F 129, S 8, H B 331105, I/A 29 ( 7.04.22).
- Extinción
14/05/2021 Detalles del anuncio (226365) Datos registrales: T 46935 , F 129, S 8, H B 331105, I/A 28 ( 6.05.21).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: BARON CERVELLO CHANTAL.
14/05/2021 Detalles del anuncio (226358) Datos registrales: T 46935 , F 128, S 8, H B 331105, I/A 27 ( 6.05.21).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: LOPEZ MONZO TERESA.
22/01/2021 Detalles del anuncio (30415) Datos registrales: T 46935 , F 126, S 8, H B 331105, I/A 26 (14.01.21).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: KAREL JULIEN MARC DANES.
29/12/2020 Detalles del anuncio (464263) Datos registrales: T 46935 , F 125, S 8, H B 331105, I/A 25 (18.12.20).
- Revocaciones
REPR.143 RRM: RAVENTOS BASAGOITI RAMON.
- Nombramientos
REPR.143 RRM: FUSTER MERINO SERGIO.
03/08/2020 Detalles del anuncio (250770) Datos registrales: T 46935 , F 125, S 8, H B 331105, I/A 24 (24.07.20).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: PKF AUDIEC SAP.
15/06/2020 Detalles del anuncio (180988) Datos registrales: T 46935 , F 121, S 8, H B 331105, I/A 23 ( 8.06.20).
- Fusión por Absorción
Sociedades absorbidas: BODEGUES SIGNAT SL. CONSTANTINO SABADO OLIVER SA.
09/06/2020 Detalles del anuncio (174891) Datos registrales: T 46935 , F 120, S 8, H B 331105, I/A 22 ( 2.06.20).
- Otros Conceptos
CANCELACION DE GARANTIAS DE LA EMISION DE OBLIGACIONES.
18/07/2019 Detalles del anuncio (309637) Datos registrales: T 46935 , F 119, S 8, H B 331105, I/A 20 ( 9.07.19).
- Modificaciones Estatutarias
ART.33 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE JULIO Y FINALIZANDO EL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO.
- Cambio de domicilio social
LG CAN CODORNIU,AV JAUME CODORNIU,S/N (SANT SADURNI DANOIA).
18/07/2019 Detalles del anuncio (309639) Datos registrales: T 46935 , F 120, S 8, H B 331105, I/A 21 ( 9.07.19).
- Otros Conceptos
DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO, SIENDO EL NUEVO ACCIONISTA UNICO: UNIDECO S.A.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 25
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-73-08 | 18/04/2022 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2021-90-08 | 14/05/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2021-90-08 | 14/05/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2021-14-08 | 22/01/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-248-08 | 29/12/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-148-08 | 03/08/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-113-08 | 15/06/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-109-08 | 09/06/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-136-08 | 18/07/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-136-08 | 18/07/2019 | Barcelona | Descargar |