GETINSA INGENIERIA SL

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 06/02/2015

RODENAS FRAILE JUAN CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2015

ARRARTE RUBIO CARLOS

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2015

CHAMORRO MERA OSCAR

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2015

MORALES FUENTECILLA ANGEL-RICARDO

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2015

ZAPARDIEL GARCIA JUAN

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2015

VILAPLANA CORTES ALBERTO

Apoderado
Nombramiento: 06/02/2015

JAUREGUI REAL GUILLERMO

Apoderado
Cese: 25/07/2014

ZUBIAUR GONZALEZ CESAR

Consejero
Nombramiento: 25/07/2014

SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 07/04/2014

GUTIERREZ VEGA JOSE RAMIRO

Apoderado solidario
Nombramiento: 27/03/2013

GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2013

LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2013

SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2013

ZUBIAUR GONZALEZ CESAR

Apoderado
Cese: 25/03/2013

GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL

Apoderado
Cese: 25/03/2013

LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA

Apoderado
Cese: 25/03/2013

GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO

Apoderado
Cese: 25/03/2013

SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO

Apoderado
Cese: 25/03/2013

ZUBIAUR GONZALEZ CESAR

Apoderado
Nombramiento: 06/03/2013

GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL

Apoderado
Nombramiento: 06/03/2013

LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA

Apoderado
Nombramiento: 06/03/2013

SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 06/03/2013

ZUBIAUR GONZALEZ CESAR

Apoderado
Nombramiento: 06/03/2013

GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO

Apoderado
Cese: 06/03/2013

GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL

Consejero
Cese: 06/03/2013

GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL

Presidente
Cese: 06/03/2013

LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA

Consejero
Cese: 06/03/2013

LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA

Secretario
Cese: 06/03/2013

GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO

Consejero
Cese: 06/03/2013

SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO

Consejero
Cese: 06/03/2013

ZUBIAUR GONZALEZ CESAR

Consejero
Nombramiento: 06/03/2013

GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL

Presidente
Nombramiento: 06/03/2013

LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA

Secretario
Nombramiento: 06/03/2013

GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL

Consejero
Nombramiento: 06/03/2013

LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA

Consejero
Nombramiento: 06/03/2013

ZUBIAUR GONZALEZ CESAR

Consejero
Cese: 16/03/2012

FERNANDO MUÑOZ AUDITORES SL

Auditor
Cese: 16/03/2012

FERNANDO MUÑOZ AUDITORES SL

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 16/03/2012

BARROSO GONZALEZ EMILIO

Auditor
Nombramiento: 16/03/2012

BARROSO GONZALEZ EMILIO

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 16/03/2012

LOPEZ ROSALES ROGELIO

Auditor suplente
Nombramiento: 16/03/2012

LOPEZ ROSALES ROGELIO

Auditor suplente cuentas consolidadas
Nombramiento: 15/12/2010

MEAN PHILIPPE B

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GETINSA INGENIERIA SL

03/03/2015 Detalles del anuncio (92481) Datos registrales: T 26421 , F 208, S 8, H M 413627, I/A 24 (23.02.15).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-.

  • Cambio de denominación social

    GETINSA-PAYMA SL.

26/02/2015 Detalles del anuncio (85549) Datos registrales: T 26421 , F 203, S 8, H M 413627, I/A 23 (19.02.15).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 1.299.728,61 Euros. Resultante Suscrito: 7.595.804,61 Euros.

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: PAYMA COTAS SL.

06/02/2015 Detalles del anuncio (54311) Datos registrales: T 26421 , F 201, S 8, H M 413627, I/A 22 (30.01.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: RODENAS FRAILE JUAN CARLOS;ARRARTE RUBIO CARLOS;CHAMORRO MERA OSCAR;MORALES FUENTECILLA ANGEL-RICARDO;ZAPARDIEL GARCIA JUAN;VILAPLANA CORTES ALBERTO;JAUREGUI REAL GUILLERMO.

25/07/2014 Detalles del anuncio (307254) Datos registrales: T 26421 , F 200, S 8, H M 413627, I/A 21 (17.07.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ZUBIAUR GONZALEZ CESAR.

  • Nombramientos

    Consejero: SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO.

07/04/2014 Detalles del anuncio (154301) Datos registrales: T 25273 , F 174, S 8, H M 413627, I/A 20 (31.03.14).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: GUTIERREZ VEGA JOSE RAMIRO.

09/01/2014 Detalles del anuncio (7241) Datos registrales: T 25273 , F 174, S 8, H M 413627, I/A 19 (31.12.13).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 116.834,40 Euros. Resultante Suscrito: 6.296.076,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Supresión de los artículos 6 y 8. Y del punto 8 del articulo 33 y del párrafo 2 del articulo 34 de los Estatutos .

27/03/2013 Detalles del anuncio (147996) Datos registrales: T 25273 , F 173, S 8, H M 413627, I/A 18 (20.03.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL;LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR.

25/03/2013 Detalles del anuncio (142033) Datos registrales: T 25273 , F 172, S 8, H M 413627, I/A 17 (14.03.13).

  • Revocaciones

    Apoderado: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL;LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA;GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR.

06/03/2013 Detalles del anuncio (112207) Datos registrales: T 25273 , F 170, S 8, H M 413627, I/A 15 (25.02.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL;LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR.

06/03/2013 Detalles del anuncio (112208) Datos registrales: T 25273 , F 171, S 8, H M 413627, I/A 16 (25.02.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 23

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-42-28 03/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-39-28 26/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-25-28 06/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-140-28 25/07/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-67-28 07/04/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-5-28 09/01/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-59-28 27/03/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-57-28 25/03/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-45-28 06/03/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-45-28 06/03/2013 Madrid Descargar