GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL

Activa

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 14/11/2024

RUIZ FERREIRO PABLO

Secretario no consejero
Cese: 14/11/2024

MARTINEZ SAENZ DE JUBERA AZUCENA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 14/11/2024

MARTINEZ SAENZ DE JUBERA AZUCENA

Secretario no consejero
Cese: 03/03/2022

ANTOLIN GRANET EMMA

Apoderado mancomunado
Cese: 03/03/2022

SANTIUSTE GARCIA RAMIRO

Apoderado mancomunado
Cese: 03/03/2022

RUIZ FERREIRO PABLO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 03/03/2022

RUIZ FERREIRO PABLO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 03/03/2022

AMO ALBALA LUIS

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 28/10/2021

INJAT SL

Consejero delegado mancomunado
Cese: 28/10/2021

INJAT SL

Consejero
Cese: 28/10/2021

AGRICOLA CINEGETICA SAN QUIRCE SL

Consejero
Cese: 28/10/2021

INJAT SL

Vicepresidente
Cese: 28/10/2021

INJAT SL

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 28/10/2021

INJAT SL

Consejero
Nombramiento: 28/10/2021

SANTA JULITA SL

Consejero
Nombramiento: 28/10/2021

INJAT SL

Vicepresidente
Nombramiento: 30/08/2016

SAIZ RODRIGO MARIA BEGOÑA

Apoderado
Nombramiento: 18/02/2016

CANEA SL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 18/02/2016

INJAT SL

Consejero delegado solidario
Cese: 18/02/2016

ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO

Consejero
Cese: 18/02/2016

ANTOLIN TOLEDANO JOSE

Consejero
Cese: 18/02/2016

RUIZ FERREIRO PABLO

Consejero
Cese: 18/02/2016

RUIZ FERREIRO PABLO

Secretario
Cese: 18/02/2016

ANTOLIN TOLEDANO JOSE

Presidente
Cese: 18/02/2016

ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO

Vicepresidente
Cese: 18/02/2016

ANTOLIN TOLEDANO JOSE

Consejero delegado solidario
Cese: 18/02/2016

ANTOLIN ARRIBAS ERNESTO

Consejero delegado solidario
Cese: 18/02/2016

VEGA GOICOLEA LUIS

Consejero
Nombramiento: 18/02/2016

CANEA SL

Consejero
Nombramiento: 18/02/2016

INJAT SL

Consejero
Nombramiento: 18/02/2016

AGRICOLA CINEGETICA SAN QUIRCE SL

Consejero
Nombramiento: 18/02/2016

AMPABER SL

Consejero
Nombramiento: 18/02/2016

CANEA SL

Presidente
Nombramiento: 18/02/2016

INJAT SL

Vicepresidente
Nombramiento: 18/02/2016

RUIZ FERREIRO PABLO

Secretario no consejero
Nombramiento: 18/02/2016

MARTINEZ SAENZ DE JUBERA AZUCENA

Vicesecretario no consejero
Cese: 02/02/2016

VEGA GOICOLEA LUIS

Apoderado mancomunado
Cese: 02/02/2016

RUIZ FERREIRO PABLO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 02/02/2016

ANTOLIN GRANET EMMA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 02/02/2016

SANTIUSTE GARCIA RAMIRO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 02/02/2016

RUIZ FERREIRO PABLO

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 05/11/2013

VEGA GOICOLEA LUIS

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 05/11/2013

RUIZ FERREIRO PABLO

Apoderado mancomunado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GESTORA DE INVERSIONES ENEREN XXI SL

14/11/2024 Detalles del anuncio (487419) Datos registrales: S 8 , H BU 6156, I/A 29 ( 8.11.24).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: RUIZ FERREIRO PABLO. VsecrNoConsj: MARTINEZ SAENZ DE JUBERA AZUCENA.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: MARTINEZ SAENZ DE JUBERA AZUCENA.

01/12/2023 Detalles del anuncio (513203) Datos registrales: T 703, L 494, F 38, S 8, H BU 6156, I/A 27 (24.11.23).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 584.773,00 Euros. Resultante Suscrito: 763.029,60 Euros.

17/11/2022 Detalles del anuncio (501101) Datos registrales: T 703, L 494, F 37, S 8, H BU 6156, I/A 25 (11.11.22).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1.400.330,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.347.802,60 Euros.

03/03/2022 Detalles del anuncio (95048) Datos registrales: T 703, L 494, F 35, S 8, H BU 6156, I/A 24 (25.02.22).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: ANTOLIN GRANET EMMA;SANTIUSTE GARCIA RAMIRO;RUIZ FERREIRO PABLO.

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: RUIZ FERREIRO PABLO;AMO ALBALA LUIS.

28/10/2021 Detalles del anuncio (472887) Datos registrales: T 703, L 494, F 34, S 8, H BU 6156, I/A 22 (22.10.21).

  • Nombramientos

    Cons.Del.Man: INJAT SL.

28/10/2021 Detalles del anuncio (472886) Datos registrales: T 703, L 494, F 34, S 8, H BU 6156, I/A 21 (22.10.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: INJAT SL.;AGRICOLA CINEGETICA SAN QUIRCE SL. Vicepresid.: INJAT SL. Cons.Del.Man: INJAT SL.

  • Nombramientos

    Consejero: INJAT SL;SANTA JULITA SL. Vicepresid.: INJAT SL.

01/07/2021 Detalles del anuncio (318730) Datos registrales: T 703, L 494, F 33, S 8, H BU 6156, I/A 20 (25.06.21).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 6.872.074,40 Euros. Resultante Suscrito: 2.748.132,60 Euros.

30/11/2020 Detalles del anuncio (418643) Datos registrales: T 703, L 494, F 32, S 8, H BU 6156, I/A 19 (24.11.20).

  • Ampliación del Objeto Social

    Se amplia el objeto en cuanto a: La explotación agrícola ganadera y forestal de fincas rústicas y la comercialización o industrialización de los productos obtenidos.

13/03/2018 Detalles del anuncio (116311) Datos registrales: T 703, L 494, F 32, S 8, H BU 6156, I/A 18 ( 7.03.18).

  • Otros Conceptos

    MODIFICACION DEL MODO DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS SOLIDARIOS CANEA SL E INJAT SL QUE PASAN A SER CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS.

30/08/2016 Detalles del anuncio (358569) Datos registrales: T 703, L 494, F 32, S 8, H BU 6156, I/A 17 (24.08.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: SAIZ RODRIGO MARIA BEGOÑA.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-220-09 14/11/2024 Burgos Descargar
BORME-A-2023-229-09 01/12/2023 Burgos Descargar
BORME-A-2022-219-09 17/11/2022 Burgos Descargar
BORME-A-2022-43-09 03/03/2022 Burgos Descargar
BORME-A-2021-208-09 28/10/2021 Burgos Descargar
BORME-A-2021-208-09 28/10/2021 Burgos Descargar
BORME-A-2021-124-09 01/07/2021 Burgos Descargar
BORME-A-2020-230-09 30/11/2020 Burgos Descargar
BORME-A-2018-51-09 13/03/2018 Burgos Descargar
BORME-A-2016-165-09 30/08/2016 Burgos Descargar