GESCABLE SL

Activa

CALLE AFRODITA (PG IND R-2 MECO), 2
 Meco, Madrid  (28880)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 03/01/2023

NER AUDITORES SLP

Auditor
Nombramiento: 13/12/2021

LOPEZ TORRALBA RAUL

Apoderado
Nombramiento: 27/01/2021

NER AUDITORES SLP

Auditor
Nombramiento: 20/04/2018

LOPEZ TORRALBA RAUL

Apoderado
Cese: 23/02/2018

RODRIGUEZ DIAZ MARIA ELENA

Administrador único
Nombramiento: 23/02/2018

GOMEZ ALONSO BEATRIZ

Administrador único
Cese: 14/03/2016

GOMEZ ALONSO CESAR

Administrador único
Nombramiento: 14/03/2016

RODRIGUEZ DIAZ MARIA ELENA

Administrador único
Cese: 21/04/2015

LOPEZ GARCIA JOSE

Apoderado
Cese: 21/04/2015

LOPEZ TORRALBA RAUL

Apoderado
Nombramiento: 21/04/2015

LOPEZ TORRALBA RAUL

Apoderado
Nombramiento: 22/04/2010

NER AUDITORES SLP

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por GESCABLE SL

03/01/2023 Detalles del anuncio (5272) Datos registrales: T 36754 , F 91, S 8, H M 140613, I/A 24 (27.12.22).

  • Reelecciones

    Auditor: NER AUDITORES SLP.

13/12/2021 Detalles del anuncio (534570) Datos registrales: T 36754 , F 91, S 8, H M 140613, I/A 23 ( 2.12.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: LOPEZ TORRALBA RAUL.

27/01/2021 Detalles del anuncio (39536) Datos registrales: T 36754 , F 91, S 8, H M 140613, I/A 22 (20.01.21).

  • Nombramientos

    Auditor: NER AUDITORES SLP.

07/05/2018 Detalles del anuncio (193880) Datos registrales: T 36754 , F 90, S 8, H M 140613, I/A 21 (26.04.18).

  • Modificaciones Estatutarias

    SE MODIFICA EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. .

20/04/2018 Detalles del anuncio (174909) Datos registrales: T 36754 , F 90, S 8, H M 140613, I/A 20 (13.04.18).

  • Nombramientos

    Apoderado: LOPEZ TORRALBA RAUL.

23/02/2018 Detalles del anuncio (88897) Datos registrales: T 36754 , F 90, S 8, H M 140613, I/A 19 (14.02.18).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: RODRIGUEZ DIAZ MARIA ELENA.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GOMEZ ALONSO BEATRIZ.

14/03/2016 Detalles del anuncio (118046) Datos registrales: T 29124 , F 71, S 8, H M 140613, I/A 18 ( 4.03.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: GOMEZ ALONSO CESAR.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: RODRIGUEZ DIAZ MARIA ELENA.

21/04/2015 Detalles del anuncio (163907) Datos registrales: T 29124 , F 70, S 8, H M 140613, I/A 17 (13.04.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: LOPEZ GARCIA JOSE;LOPEZ TORRALBA RAUL.

  • Nombramientos

    Apoderado: LOPEZ TORRALBA RAUL.

11/10/2011 Detalles del anuncio (403835) Datos registrales: T 8739 , F 97, S 8, H M 140613, I/A 16 (29.09.11).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 90.540,00 Euros. Resultante Suscrito: 475.540,00 Euros.

02/11/2010 Detalles del anuncio (956598)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2023-2-28 03/01/2023 Madrid Descargar
BORME-A-2021-236-28 13/12/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2021-17-28 27/01/2021 Madrid Descargar
BORME-A-2018-86-28 07/05/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-77-28 20/04/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2018-39-28 23/02/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2016-50-28 14/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-74-28 21/04/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2011-194-28 11/10/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-210-28 02/11/2010 Madrid Descargar