FRANKDAI SA

Extinta

AV DE LALCALDE BARNILS 64-68 EDIF.B PL.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 30/08/2013

FERRER PELLICER IGNACIO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 30/08/2013

XAMPENY TERRISSE VICTOR

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 30/08/2013

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 30/08/2013

DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 30/08/2013

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 30/08/2013

MESTRE MARTIN FRANCISCO

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 30/08/2013

RUBIO RODRIGUEZ ADELA

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/08/2013

ROLDAN SORIA NOELIA

Apoderado solidario mancomunado
Nombramiento: 30/08/2013

VALLE ZAYAS OLGA

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/08/2013

RENOM LLONCH ANNA

Apoderado solidario
Cese: 29/12/2011

PEREIRA DAVILA VICTOR

Apoderado
Cese: 16/08/2011

DEL RIO FERNANDEZ JOSE

Apoderado
Nombramiento: 16/08/2011

ROLDAN SORIA NOELIA

Apoderado
Nombramiento: 16/08/2011

BERMUDO ESCRIBANO JUAN

Apoderado
Cese: 18/05/2011

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 18/05/2011

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado
Cese: 11/05/2011

JEREZ BURDEUS SONIA

Apoderado
Cese: 11/05/2011

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 11/05/2011

DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO

Apoderado
Nombramiento: 11/05/2011

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Cese: 11/05/2011

JEREZ BURDEUS SONIA

Consejero
Nombramiento: 11/05/2011

XAMPENY TERRISSE VICTOR

Consejero
Cese: 04/05/2010

CHINCHILLA LOPEZ JORDI

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

JEREZ BURDEUS SONIA

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

XAMPENY TERRISSE VICTOR

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

JUANES RIPOLL CARMEN

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

MESTRE MARTIN FRANCISCO JOSE

Apoderado
Cese: 04/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Apoderado
Cese: 04/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Apoderado
Cese: 04/05/2010

IGLESIAS PUJOL IGNACIO

Apoderado
Cese: 04/05/2010

JEREZ BURDEUS SONIA

Apoderado
Cese: 04/05/2010

TERRER NADAL JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 04/05/2010

XAMPENY TERRISSE VICTOR

Apoderado
Cese: 04/05/2010

DOMEQUE SORRIBAS ENRIQUE

Apoderado
Cese: 04/05/2010

MARTINEZ DE PABLO MARIA TERESA

Apoderado
Cese: 04/05/2010

CAMARASA FIGUERES MARC

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

DEL RIO FERNANDEZ JOSE

Apoderado
Nombramiento: 04/05/2010

PEREIRA DAVILA VICTOR

Apoderado
Cese: 04/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Consejero
Cese: 04/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Secretario
Cese: 04/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Consejero
Cese: 04/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Presidente
Cese: 04/05/2010

MORA GRISO GUILLERMO

Consejero
Nombramiento: 04/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Consejero
Nombramiento: 04/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 04/05/2010

JEREZ BURDEUS SONIA

Consejero
Nombramiento: 04/05/2010

FERRER PELLICER IGNACIO

Presidente
Nombramiento: 04/05/2010

DOMINGO GISPERT ANTONIO

Secretario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FRANKDAI SA

27/10/2014 Detalles del anuncio (430690) Datos registrales: T 42908 , F 5, S 8, H B 149557, I/A 54 (16.10.14).

  • Extinción

11/03/2014 Detalles del anuncio (109168) Datos registrales: T 42908 , F 4, S 8, H B 149557, I/A 53 ( 3.03.14).

  • Cambio de domicilio social

    AV DE LALCALDE BARNILS 64-68 EDIF.B PL.1 (SANT CUGAT DEL VALLES).

30/08/2013 Detalles del anuncio (382255) Datos registrales: T 42908 , F 1, S 8, H B 149557, I/A 52 (22.08.13).

  • Nombramientos

    APOD.SOL/MAN: FERRER PELLICER IGNACIO;XAMPENY TERRISSE VICTOR;DOMINGO GISPERT ANTONIO;DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO;IGLESIAS PUJOL IGNACIO;MESTRE MARTIN FRANCISCO. APODERAD.SOL: RUBIO RODRIGUEZ ADELA. APOD.SOL/MAN: ROLDAN SORIA NOELIA. APODERAD.SOL: VALLE ZAYAS OLGA;RENOM LLONCH ANNA.

29/12/2011 Detalles del anuncio (520776) Datos registrales: T 42908 , F 1, S 8, H B 149557, I/A 51 (21.12.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: PEREIRA DAVILA VICTOR.

21/09/2011 Detalles del anuncio (565066)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

16/08/2011 Detalles del anuncio (338107) Datos registrales: T 40767 , F 179, S 8, H B 149557, I/A 50 ( 3.08.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: DEL RIO FERNANDEZ JOSE.

  • Nombramientos

    APODERADO: ROLDAN SORIA NOELIA;BERMUDO ESCRIBANO JUAN.

18/05/2011 Detalles del anuncio (211432) Datos registrales: T 41820 , F 176, S 8, H B 149557, I/A 49 ( 6.05.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: DOMINGO GISPERT ANTONIO.

  • Nombramientos

    APODERADO: DOMINGO GISPERT ANTONIO.

11/05/2011 Detalles del anuncio (200438) Datos registrales: T 41820 , F 173, S 8, H B 149557, I/A 48 (28.04.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: JEREZ BURDEUS SONIA;IGLESIAS PUJOL IGNACIO.

  • Nombramientos

    APODERADO: DE LA CRUZ LOPEZ FERNANDO;IGLESIAS PUJOL IGNACIO.

11/05/2011 Detalles del anuncio (200436) Datos registrales: T 41820 , F 73, S 8, H B 149557, I/A 47 (28.04.11).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: JEREZ BURDEUS SONIA.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: XAMPENY TERRISSE VICTOR.

25/11/2010 Detalles del anuncio (1098660)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2014-205-08 27/10/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-48-08 11/03/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-165-08 30/08/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-246-08 29/12/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-180-08 21/09/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-155-08 16/08/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-94-08 18/05/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-89-08 11/05/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-89-08 11/05/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-226-08 25/11/2010 Barcelona Descargar