FONDIM 104 SA

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 22/10/2020

JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO SLP

Administrador concurs.
Cese: 22/10/2020

BOU MAQUEDA AGUSTI

Representante administrador concurs.
Nombramiento: 12/06/2013

JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO SLP

Administrador concurs.
Nombramiento: 12/06/2013

BOU MAQUEDA AGUSTI

Representante administrador concurs.
Cese: 25/09/2012

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Consejero
Cese: 25/09/2012

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Presidente
Cese: 25/09/2012

PONTEGADEA INVERSIONES SL

Consejero
Cese: 25/09/2012

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Consejero delegado mancomunado
Cese: 25/09/2012

ARNAU SIERRA JOSE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 25/09/2012

ESPARELLE INMOBILIARIA SL

Consejero
Nombramiento: 25/09/2012

ARNAU SIERRA JOSE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 25/09/2012

TAUR SL

Consejero
Nombramiento: 25/09/2012

TAUR SL

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 25/09/2012

TAUR SL

Presidente
Nombramiento: 25/09/2012

BAYER RAICH JOSEP MARIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 20/07/2012

VILALLONGA SHELLY DAVID

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 20/07/2012

DIAZ FAVA ROBERT

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 12/04/2012

CANTALLOPS GUAL ANTONIO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 12/04/2012

MEDINA MIGUEL MARIA ELENA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FONDIM 104 SA

22/10/2020 Detalles del anuncio (357645) Datos registrales: T 41538 , F 38, S 8, H B 155256, I/A 24 (15.10.20).

  • Revocaciones

    ADM.CONCURS.: JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO SLP. REP.ADM.CONC: BOU MAQUEDA AGUSTI.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 122/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/09/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

  • Extinción

07/03/2019 Detalles del anuncio (105589) Datos registrales: T 29564 , F 102, S 8, H B 155256, I/A 4 N (26.02.19).

  • Otros Conceptos

    LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA QUEDA DISUELTA POR TRANSCURSO DEL PLAZO DE DURACION DE CONFORMDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 238.1 RRM.

  • Disolución

    Otras Causas.

12/06/2013 Detalles del anuncio (268989) Datos registrales: T 41538 , F 38, S 8, H B 155256, I/A 23 ( 5.06.13).

  • Nombramientos

    ADM.CONCURS.: JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO SLP. REP.ADM.CONC: BOU MAQUEDA AGUSTI.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 122/2013, AUTO FIRME DE FECHA 08/03/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

25/09/2012 Detalles del anuncio (392157) Datos registrales: T 41538 , F 36, S 8, H B 155256, I/A 22 (17.09.12).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: BAYER RAICH JOSEP MARIA. PRESIDENTE: BAYER RAICH JOSEP MARIA. CONSEJERO: PONTEGADEA INVERSIONES SL. CONS.DEL.MAN: BAYER RAICH JOSEP MARIA. REPR.143 RRM: ARNAU SIERRA JOSE.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: ESPARELLE INMOBILIARIA SL. REPR.143 RRM: ARNAU SIERRA JOSE. CONSEJERO: TAUR SL. CONS.DEL.MAN: TAUR SL. PRESIDENTE: TAUR SL. REPR.143 RRM: BAYER RAICH JOSEP MARIA.

20/07/2012 Detalles del anuncio (306985) Datos registrales: T 41538 , F 36, S 8, H B 155256, I/A 21 (10.07.12).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: VILALLONGA SHELLY DAVID.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: DIAZ FAVA ROBERT.

12/04/2012 Detalles del anuncio (163314) Datos registrales: T 41538 , F 36, S 8, H B 155256, I/A 20 (28.03.12).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: CANTALLOPS GUAL ANTONIO.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: MEDINA MIGUEL MARIA ELENA.

27/10/2011 Detalles del anuncio (869321)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

25/08/2010 Detalles del anuncio (366610)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2010) Año: 2009

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 8

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2020-205-08 22/10/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-46-08 07/03/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-109-08 12/06/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-185-08 25/09/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-138-08 20/07/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-70-08 12/04/2012 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-205-08 27/10/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-163-08 25/08/2010 Barcelona Descargar