FLEXICEL SA

Cambio de denominación social

AVENIDA FRANCESC MACIA, 265 - LOC 10
 Esparreguera, Barcelona  (08292)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 10/03/2021

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Administrador único
Nombramiento: 27/01/2021

AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 19/11/2020

SANCHEZ JAEN MARIA DE LA CONCEPCION

Apoderado solidario
Nombramiento: 24/06/2020

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Administrador único
Nombramiento: 04/07/2014

SANCHEZ JAEN MARIA CONCEPCION

Administrador suplente
Nombramiento: 04/07/2014

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Administrador único
Cese: 17/01/2014

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Administrador solidario
Cese: 04/11/2013

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Consejero
Cese: 04/11/2013

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Vicepresidente
Cese: 04/11/2013

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Consejero delegado
Cese: 04/11/2013

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Consejero
Cese: 04/11/2013

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Presidente
Cese: 04/11/2013

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Consejero delegado
Cese: 04/11/2013

GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL

Consejero
Cese: 04/11/2013

GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL

Secretario
Nombramiento: 04/11/2013

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Administrador solidario
Nombramiento: 04/11/2013

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Administrador solidario
Nombramiento: 28/03/2012

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Consejero
Nombramiento: 28/03/2012

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Vicepresidente
Nombramiento: 28/03/2012

NAVARRO INIESTA JUAN JOSE

Consejero delegado
Nombramiento: 28/03/2012

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Consejero
Nombramiento: 28/03/2012

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Presidente
Nombramiento: 28/03/2012

GONZALEZ RATON JOSE LUIS

Consejero delegado
Nombramiento: 28/03/2012

GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL

Consejero
Nombramiento: 28/03/2012

GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL

Secretario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FLEXICEL SA

10/03/2021 Detalles del anuncio (113093) Datos registrales: T 47507 , F 22, S 8, H B 83588, I/A 41 ( 2.03.21).

  • Transformación de Sociedad

    Denominación y forma adoptada: JOLUYCON SL.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: GONZALEZ RATON JOSE LUIS.

  • Otros Conceptos

    REVOCACION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA:GAESCO BOLSA SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA SA.

  • Cambio de denominación social

    JOLUYCON SL.

27/01/2021 Detalles del anuncio (38257) Datos registrales: T 47507 , F 22, S 8, H B 83588, I/A 40 (18.01.21).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP.

28/12/2020 Detalles del anuncio (461473) Datos registrales: T 47507 , F 21, S 8, H B 83588, I/A 39 (17.12.20).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 7.512,50 Euros. Resultante Suscrito: 64.908,00 Euros.

19/11/2020 Detalles del anuncio (401682) Datos registrales: T 47507 , F 21, S 8, H B 83588, I/A 38 (11.11.20).

  • Nombramientos

    APODERAD.SOL: SANCHEZ JAEN MARIA DE LA CONCEPCION.

24/06/2020 Detalles del anuncio (191630) Datos registrales: T 39752 , F 40, S 8, H B 83588, I/A 37 (16.06.20).

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: GONZALEZ RATON JOSE LUIS.

28/11/2018 Detalles del anuncio (475112) Datos registrales: T 39752 , F 40, S 8, H B 83588, I/A 36 (20.11.18).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 6.310,50 Euros. Resultante Suscrito: 72.420,50 Euros.

11/03/2016 Detalles del anuncio (115107) Datos registrales: T 39752 , F 39, S 8, H B 83588, I/A 35 ( 3.03.16).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 13.222,00 Euros. Resultante Suscrito: 78.731,00 Euros.

05/06/2015 Detalles del anuncio (227149) Datos registrales: T 39752 , F 39, S 8, H B 83588, I/A 34 (27.05.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 22.958,20 Euros. Resultante Suscrito: 91.953,00 Euros.

20/02/2015 Detalles del anuncio (76069) Datos registrales: T 39752 , F 37, S 8, H B 83588, I/A 33 (12.02.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 28.727,80 Euros. Resultante Suscrito: 114.911,20 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    ART 5.-SUPRESION CLASES DE ACCIONES Y RENUMERACION;ART 8.-LIMITACIONES A LA TRANSMISIBILIDAD,ART 9.- REQUISITOS PARA PROCEDER A LA TRANSMISION DE ACCIONESACTOS INTER VIVOS,ART 10.-REQUISITOS PARA PROCEDER A LA TRANSMISION ACCIONES MORTIS CAUSA.

04/07/2014 Detalles del anuncio (276809) Datos registrales: T 39752 , F 37, S 8, H B 83588, I/A 32 (26.06.14).

  • Nombramientos

    ADM.SUPLENTE: SANCHEZ JAEN MARIA CONCEPCION. ADM.UNICO: GONZALEZ RATON JOSE LUIS.

  • Modificaciones Estatutarias

    ART.21: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 17

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-47-08 10/03/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2021-17-08 27/01/2021 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-247-08 28/12/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-223-08 19/11/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-120-08 24/06/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-228-08 28/11/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-49-08 11/03/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-104-08 05/06/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-35-08 20/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-125-08 04/07/2014 Barcelona Descargar