FLEXICEL SA
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 10/03/2021 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Administrador único |
| Nombramiento: 27/01/2021 | AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP |
Auditor de cuentas |
| Nombramiento: 19/11/2020 | SANCHEZ JAEN MARIA DE LA CONCEPCION |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 24/06/2020 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Administrador único |
| Nombramiento: 04/07/2014 | SANCHEZ JAEN MARIA CONCEPCION |
Administrador suplente |
| Nombramiento: 04/07/2014 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Administrador único |
| Cese: 17/01/2014 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Administrador solidario |
| Cese: 04/11/2013 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Consejero |
| Cese: 04/11/2013 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Vicepresidente |
| Cese: 04/11/2013 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Consejero delegado |
| Cese: 04/11/2013 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Consejero |
| Cese: 04/11/2013 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Presidente |
| Cese: 04/11/2013 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Consejero delegado |
| Cese: 04/11/2013 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL |
Consejero |
| Cese: 04/11/2013 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL |
Secretario |
| Nombramiento: 04/11/2013 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 04/11/2013 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Administrador solidario |
| Nombramiento: 28/03/2012 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 28/03/2012 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Vicepresidente |
| Nombramiento: 28/03/2012 | NAVARRO INIESTA JUAN JOSE |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 28/03/2012 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 28/03/2012 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Presidente |
| Nombramiento: 28/03/2012 | GONZALEZ RATON JOSE LUIS |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 28/03/2012 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL |
Consejero |
| Nombramiento: 28/03/2012 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL |
Secretario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FLEXICEL SA
10/03/2021 Detalles del anuncio (113093) Datos registrales: T 47507 , F 22, S 8, H B 83588, I/A 41 ( 2.03.21).
- Transformación de Sociedad
Denominación y forma adoptada: JOLUYCON SL.
- Nombramientos
ADM.UNICO: GONZALEZ RATON JOSE LUIS.
- Otros Conceptos
REVOCACION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA:GAESCO BOLSA SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA SA.
- Cambio de denominación social
JOLUYCON SL.
27/01/2021 Detalles del anuncio (38257) Datos registrales: T 47507 , F 22, S 8, H B 83588, I/A 40 (18.01.21).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP.
28/12/2020 Detalles del anuncio (461473) Datos registrales: T 47507 , F 21, S 8, H B 83588, I/A 39 (17.12.20).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 7.512,50 Euros. Resultante Suscrito: 64.908,00 Euros.
19/11/2020 Detalles del anuncio (401682) Datos registrales: T 47507 , F 21, S 8, H B 83588, I/A 38 (11.11.20).
- Nombramientos
APODERAD.SOL: SANCHEZ JAEN MARIA DE LA CONCEPCION.
24/06/2020 Detalles del anuncio (191630) Datos registrales: T 39752 , F 40, S 8, H B 83588, I/A 37 (16.06.20).
- Nombramientos
ADM.UNICO: GONZALEZ RATON JOSE LUIS.
28/11/2018 Detalles del anuncio (475112) Datos registrales: T 39752 , F 40, S 8, H B 83588, I/A 36 (20.11.18).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 6.310,50 Euros. Resultante Suscrito: 72.420,50 Euros.
11/03/2016 Detalles del anuncio (115107) Datos registrales: T 39752 , F 39, S 8, H B 83588, I/A 35 ( 3.03.16).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 13.222,00 Euros. Resultante Suscrito: 78.731,00 Euros.
05/06/2015 Detalles del anuncio (227149) Datos registrales: T 39752 , F 39, S 8, H B 83588, I/A 34 (27.05.15).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 22.958,20 Euros. Resultante Suscrito: 91.953,00 Euros.
20/02/2015 Detalles del anuncio (76069) Datos registrales: T 39752 , F 37, S 8, H B 83588, I/A 33 (12.02.15).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 28.727,80 Euros. Resultante Suscrito: 114.911,20 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
ART 5.-SUPRESION CLASES DE ACCIONES Y RENUMERACION;ART 8.-LIMITACIONES A LA TRANSMISIBILIDAD,ART 9.- REQUISITOS PARA PROCEDER A LA TRANSMISION DE ACCIONESACTOS INTER VIVOS,ART 10.-REQUISITOS PARA PROCEDER A LA TRANSMISION ACCIONES MORTIS CAUSA.
04/07/2014 Detalles del anuncio (276809) Datos registrales: T 39752 , F 37, S 8, H B 83588, I/A 32 (26.06.14).
- Nombramientos
ADM.SUPLENTE: SANCHEZ JAEN MARIA CONCEPCION. ADM.UNICO: GONZALEZ RATON JOSE LUIS.
- Modificaciones Estatutarias
ART.21: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 17
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2021-47-08 | 10/03/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2021-17-08 | 27/01/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-247-08 | 28/12/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-223-08 | 19/11/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-120-08 | 24/06/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-228-08 | 28/11/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2016-49-08 | 11/03/2016 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-104-08 | 05/06/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-35-08 | 20/02/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2014-125-08 | 04/07/2014 | Barcelona | Descargar |