FIBROCEMENTOS NT SA

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 30/07/2015

GALLEGO MORENO ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 30/07/2015

ESCRIVA BERTO MIGUEL

Consejero
Cese: 27/04/2015

CARRASCOSA RUIZ JOSE A

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 26/09/2014

VELASCO OSMA JOSE RAMON

Consejero
Nombramiento: 26/09/2014

VELASCO OSMA JOSE RAMON

Presidente
Cese: 01/08/2013

ALONSO HUMAYOR JOSE ANTONIO

Apoderado
Cese: 01/08/2013

MARCOS CARTELLE CARMEN MINIA

Apoderado
Cese: 19/07/2013

MARCOS CARTELLE CARMEN MINIA

Consejero
Nombramiento: 19/07/2013

GALLEGO MORENO ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 19/07/2013

DEL RIO NOVO CARMEN

Consejero
Nombramiento: 19/07/2013

DEL RIO NOVO CARMEN

Secretario
Cese: 08/11/2012

ERRAZURIZ MATTA PABLO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 26/10/2012

SANZ MARTIN JOSE LUIS

Apoderado
Cese: 26/10/2012

POZO PALOMARES JOSE LUIS

Apoderado
Cese: 26/10/2012

CHIARRI LAGUNA JOSE MARIA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 26/10/2012

ATIENZA AVILA MARTA

Apoderado
Cese: 07/08/2012

FIESTAS TEJEDOR ANTONIO

Apoderado solidario
Cese: 07/08/2012

SANZ MARTIN JOSE LUIS

Apoderado solidario
Cese: 07/08/2012

SALAZAR TEJEDOR ANGELA

Apoderado
Nombramiento: 07/08/2012

FIESTAS TEJEDOR ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 07/08/2012

GARCIA MONTERO DAVID

Apoderado
Nombramiento: 07/08/2012

SALAZAR TEJEDOR ANGELA

Apoderado
Cese: 01/03/2012

SANCHEZ PRIETO ALCAZAR JAVIER

Apoderado mancomunado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FIBROCEMENTOS NT SA

17/08/2016 Detalles del anuncio (339860) Datos registrales: T 30120 , F 130, S 8, H M 113106, I/A 240 ( 9.08.16).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

23/09/2015 Detalles del anuncio (385207) Datos registrales: T 30120 , F 129, S 8, H M 113106, I/A 239 (15.09.15).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCC.

30/07/2015 Detalles del anuncio (316497) Datos registrales: T 30120 , F 129, S 8, H M 113106, I/A 238 (22.07.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GALLEGO MORENO ENRIQUE.

  • Nombramientos

    Consejero: ESCRIVA BERTO MIGUEL.

27/04/2015 Detalles del anuncio (173168) Datos registrales: T 30120 , F 129, S 8, H M 113106, I/A 237 (17.04.15).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: CARRASCOSA RUIZ JOSE A.

26/09/2014 Detalles del anuncio (385128) Datos registrales: T 30120 , F 129, S 8, H M 113106, I/A 236 (18.09.14).

  • Reelecciones

    Consejero: VELASCO OSMA JOSE RAMON. Presidente: VELASCO OSMA JOSE RAMON.

01/08/2013 Detalles del anuncio (344828) Datos registrales: T 30120 , F 129, S 8, H M 113106, I/A 235 (24.07.13).

  • Revocaciones

    Apoderado: ALONSO HUMAYOR JOSE ANTONIO;MARCOS CARTELLE CARMEN MINIA.

19/07/2013 Detalles del anuncio (326818) Datos registrales: T 30120 , F 128, S 8, H M 113106, I/A 234 (11.07.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MARCOS CARTELLE CARMEN MINIA.

  • Nombramientos

    Consejero: GALLEGO MORENO ENRIQUE.

  • Reelecciones

    Consejero: DEL RIO NOVO CARMEN. Secretario: DEL RIO NOVO CARMEN.

08/11/2012 Detalles del anuncio (459345) Datos registrales: T 30120 , F 128, S 8, H M 113106, I/A 233 (25.10.12).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: ERRAZURIZ MATTA PABLO.

26/10/2012 Detalles del anuncio (438399) Datos registrales: T 30120 , F 128, S 8, H M 113106, I/A 232 (16.10.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: SANZ MARTIN JOSE LUIS;POZO PALOMARES JOSE LUIS.

26/10/2012 Detalles del anuncio (438398) Datos registrales: T 30120 , F 128, S 8, H M 113106, I/A 231 (15.10.12).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: CHIARRI LAGUNA JOSE MARIA. Apoderado: ATIENZA AVILA MARTA.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 21

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2016-156-28 17/08/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-182-28 23/09/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-143-28 30/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-78-28 27/04/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-184-28 26/09/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-145-28 01/08/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-136-28 19/07/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-215-28 08/11/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-207-28 26/10/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-207-28 26/10/2012 Madrid Descargar