FCC INMOBILIARIA CONYCON SL

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 03/11/2014

TORRES BADAJOZ ANGEL-MARIA

Apoderado
Nombramiento: 03/11/2014

LIEBANA ALCANTARILLA JOSE

Apoderado
Cese: 21/10/2014

MATA RODRIGUEZ MIGUEL

Apoderado
Cese: 05/06/2014

VERDU RAMOS JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 22/05/2014

PARAJA DE LA RIERA JUAN CARLOS

Apoderado
Cese: 05/05/2014

FARRE RAMOS ALBERTO

Apoderado
Nombramiento: 05/05/2014

ANDRADAS OVEJA JUAN CARLOS

Apoderado solidario
Cese: 05/05/2014

SALGADO OTONES DIEGO

Apoderado
Nombramiento: 04/04/2014

DONOSO REBUELTA JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 27/02/2014

PINO VALLADARES ANTONIO MARIA

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por FCC INMOBILIARIA CONYCON SL

16/02/2015 Detalles del anuncio (68306) Datos registrales: T 30700 , F 132, S 8, H M 35220, I/A 54 ( 9.02.15).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

03/11/2014 Detalles del anuncio (442125) Datos registrales: T 30700 , F 131, S 8, H M 35220, I/A 53 (24.10.14).

  • Nombramientos

    Apoderado: TORRES BADAJOZ ANGEL-MARIA.

03/11/2014 Detalles del anuncio (442124) Datos registrales: T 30700 , F 131, S 8, H M 35220, I/A 52 (24.10.14).

  • Nombramientos

    Apoderado: LIEBANA ALCANTARILLA JOSE.

21/10/2014 Detalles del anuncio (421200) Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 51 (13.10.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: MATA RODRIGUEZ MIGUEL.

05/06/2014 Detalles del anuncio (237882) Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 50 (29.05.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: VERDU RAMOS JOSE MARIA.

22/05/2014 Detalles del anuncio (215277) Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 49 (13.05.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: PARAJA DE LA RIERA JUAN CARLOS.

05/05/2014 Detalles del anuncio (187687) Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 47 (23.04.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: FARRE RAMOS ALBERTO.

05/05/2014 Detalles del anuncio (187688) Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 48 (23.04.14).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: ANDRADAS OVEJA JUAN CARLOS.

05/05/2014 Detalles del anuncio (187686) Datos registrales: T 30700 , F 130, S 8, H M 35220, I/A 46 (23.04.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: SALGADO OTONES DIEGO.

04/04/2014 Detalles del anuncio (151949) Datos registrales: T 30700 , F 129, S 8, H M 35220, I/A 45 (27.03.14).

  • Nombramientos

    Apoderado: DONOSO REBUELTA JOSE LUIS.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 24

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-31-28 16/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-210-28 03/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-210-28 03/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-201-28 21/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-105-28 05/06/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-95-28 22/05/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-83-28 05/05/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-83-28 05/05/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-83-28 05/05/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-66-28 04/04/2014 Madrid Descargar