ESTERITEX SA

Cambio de denominación social

C/ CAMINO DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO S/N - POLIGON (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 02/06/2015

OÑORO MEDRANO ALEJANDRO

Administrador mancomunado
Cese: 02/06/2015

CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL

Administrador mancomunado
Nombramiento: 02/06/2015

GRUPO ILUNION SA

Administrador único
Nombramiento: 02/06/2015

OÑORO MEDRANO ALEJANDRO

Representante
Nombramiento: 25/11/2014

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 25/07/2014

FUERTES GARCIA ROSA MARIA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/07/2014

BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/07/2014

NAVARRO HIGUERA MERCEDES

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/07/2014

CARRETON PINOS ANGEL

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 25/07/2014

CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 02/11/2012

OÑORO MEDRANO ALEJANDRO

Apoderado solidario
Nombramiento: 02/11/2012

CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL

Apoderado solidario
Nombramiento: 31/10/2012

CENTENO HUERTA FRANCISCO

Apoderado
Nombramiento: 03/10/2012

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 03/10/2012

ANDRES MARTINEZ MANUEL

Consejero
Cese: 03/10/2012

MARTINEZ DONOSO JOSE LUIS

Consejero
Cese: 03/10/2012

OÑORO MEDRANO ALEJANDRO

Consejero
Cese: 03/10/2012

ANDRES MARTINEZ MANUEL

Presidente
Cese: 03/10/2012

MARTINEZ DONOSO JOSE LUIS

Vicepresidente
Cese: 03/10/2012

ANDRES MARTINEZ MANUEL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 03/10/2012

OÑORO MEDRANO ALEJANDRO

Administrador mancomunado
Nombramiento: 03/10/2012

CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL

Administrador mancomunado
Cese: 07/08/2012

DEL RIO CEBRIAN PAOLA

Apoderado
Nombramiento: 07/08/2012

CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL

Apoderado
Nombramiento: 25/04/2012

DIAZ PANIAGUA MARIA ESTHER

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ESTERITEX SA

02/06/2015 Detalles del anuncio (223503) Datos registrales: T 26545 , F 196, S 8, H M 365410, I/A 24 (22.05.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Mancom.: OÑORO MEDRANO ALEJANDRO;CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: GRUPO ILUNION SA. Representan: OÑORO MEDRANO ALEJANDRO.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único.

  • Cambio de denominación social

    ILUNION ESTERILIZACION, SA.

25/11/2014 Detalles del anuncio (479943) Datos registrales: T 26545 , F 195, S 8, H M 365410, I/A 23 (17.11.14).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE SL.

25/07/2014 Detalles del anuncio (307223) Datos registrales: T 26545 , F 195, S 8, H M 365410, I/A 22 (16.07.14).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: FUERTES GARCIA ROSA MARIA;BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA;NAVARRO HIGUERA MERCEDES;CARRETON PINOS ANGEL;CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS.

02/11/2012 Detalles del anuncio (449887) Datos registrales: T 26545 , F 195, S 8, H M 365410, I/A 21 (22.10.12).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: OÑORO MEDRANO ALEJANDRO;CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL.

31/10/2012 Detalles del anuncio (447108) Datos registrales: T 26545 , F 194, S 8, H M 365410, I/A 20 (19.10.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: CENTENO HUERTA FRANCISCO.

03/10/2012 Detalles del anuncio (403355) Datos registrales: T 26545 , F 194, S 8, H M 365410, I/A 19 (21.09.12).

  • Nombramientos

    Auditor: DELOITTE SL.

03/10/2012 Detalles del anuncio (403354) Datos registrales: T 26545 , F 191, S 8, H M 365410, I/A 18 (21.09.12).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    FUNDOSA GRUPO SA.

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: ANDRES MARTINEZ MANUEL;MARTINEZ DONOSO JOSE LUIS;OÑORO MEDRANO ALEJANDRO. Presidente: ANDRES MARTINEZ MANUEL. Vicepresid.: MARTINEZ DONOSO JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: ANDRES MARTINEZ MANUEL.

  • Nombramientos

    Adm. Mancom.: OÑORO MEDRANO ALEJANDRO;CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL.

  • Modificaciones Estatutarias

    SE APRUEBA UN TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Cambio del Organo de Administración: Consejo de administracióna Administradores mancomunados.

  • Cambio de domicilio social

    C/ CAMINO DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO S/N - POLIGON (MADRID).

07/08/2012 Detalles del anuncio (331448) Datos registrales: T 26545 , F 191, S 8, H M 365410, I/A 17 (27.07.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: DEL RIO CEBRIAN PAOLA.

07/08/2012 Detalles del anuncio (331447) Datos registrales: T 26545 , F 190, S 8, H M 365410, I/A 16 (27.07.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: CUEVAS GIMENEZ CRISTOBAL.

25/04/2012 Detalles del anuncio (182309) Datos registrales: T 26545 , F 189, S 8, H M 365410, I/A 15 (16.04.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: DIAZ PANIAGUA MARIA ESTHER.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 21

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-102-28 02/06/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-225-28 25/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-140-28 25/07/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2012-211-28 02/11/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-210-28 31/10/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-191-28 03/10/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-191-28 03/10/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-150-28 07/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-150-28 07/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-79-28 25/04/2012 Madrid Descargar