EKLIPSUS GESTION DE PROYECTOS SL
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 21/07/2016 | RUIZ GALLARDON UTRERA ALBERTO |
Vicesecretario no consejero |
| Cese: 21/07/2016 | HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO |
Consejero |
| Cese: 21/07/2016 | HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 21/07/2016 | PEREZ HERVADA PAYA JOAQUIN |
Consejero delegado |
| Cese: 06/07/2015 | MONEDERO PEREZ DAVID |
Consejero |
| Cese: 10/08/2011 | OROZCO REGUERO EDUARDO NICOLAS |
Consejero |
| Cese: 24/05/2011 | PEAGO M3M SL |
Consejero |
| Cese: 24/05/2011 | GONZALEZ LOSADA MIGUEL ANGEL |
Representante |
| Nombramiento: 27/12/2010 | GARCIA FRANCES FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Cese: 13/05/2010 | MONEDERO PEREZ DAVID |
Presidente |
| Nombramiento: 13/05/2010 | RUIZ GALLARDON UTRERA ALBERTO |
Vicesecretario no consejero |
| Nombramiento: 13/05/2010 | PEREZ HERVADA PAYA JOAQUIN |
Presidente |
| Nombramiento: 13/05/2010 | HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 13/05/2010 | HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO |
Consejero |
| Nombramiento: 13/05/2010 | PEREZ PEREZ DE LECETA IÑIGO |
Consejero |
| Nombramiento: 13/05/2010 | PEAGO M3M SL |
Consejero |
| Nombramiento: 13/05/2010 | GONZALEZ LOSADA MIGUEL ANGEL |
Representante |
| Cese: 14/07/2009 | CASTELLANOS CALDEVILLA FRANCISCO |
Consejero |
| Nombramiento: 14/07/2009 | PEREZ HERVADA PAYA JOAQUIN |
Consejero |
| Nombramiento: 10/06/2009 | MONEDERO PEREZ DAVID |
Presidente |
| Nombramiento: 10/06/2009 | PEREZ DE LA CRUZ OÑA JESUS |
Secretario no consejero |
| Nombramiento: 10/06/2009 | HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por EKLIPSUS GESTION DE PROYECTOS SL
29/08/2018 Detalles del anuncio (355017) Datos registrales: T 26661 , F 211, S 8, H M 480498, I/A 15 (11.08.18).
- Cambio de denominación social
EKLIPSUS PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA.
21/07/2016 Detalles del anuncio (304298) Datos registrales: T 26661 , F 210, S 8, H M 480498, I/A 14 (13.07.16).
- Ceses/Dimisiones
VsecrNoConsj: RUIZ GALLARDON UTRERA ALBERTO. Consejero: HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO. Con.Delegado: HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO.
- Nombramientos
Con.Delegado: PEREZ HERVADA PAYA JOAQUIN.
06/07/2015 Detalles del anuncio (275358) Datos registrales: T 26661 , F 210, S 8, H M 480498, I/A 13 (26.06.15).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: MONEDERO PEREZ DAVID.
20/03/2015 Detalles del anuncio (118624) Datos registrales: T 26661 , F 210, S 8, H M 480498, I/A 12 (10.03.15).
- Modificaciones Estatutarias
MODIFICADO EL ARTICULO 23º.- PLAZO DE DURACION DEL CARGO Y REMUNERACION.
17/01/2014 Detalles del anuncio (20582) Datos registrales: T 26661 , F 209, S 8, H M 480498, I/A 11 (10.01.14).
- Ampliación de Capital
Capital: 140,20 Euros. Resultante Suscrito: 93.452,20 Euros.
- Ampliación de Capital
Capital: 963,80 Euros. Resultante Suscrito: 94.416,00 Euros.
20/06/2012 Detalles del anuncio (259727) Datos registrales: T 26661 , F 209, S 8, H M 480498, I/A 10 ( 7.06.12).
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-.
- Cambio de domicilio social
C/ VELAZQUEZ 10, 5º DCHA. (MADRID).
10/08/2011 Detalles del anuncio (333266) Datos registrales: T 26661 , F 208, S 8, H M 480498, I/A 9 (28.07.11).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: OROZCO REGUERO EDUARDO NICOLAS.
24/05/2011 Detalles del anuncio (220911) Datos registrales: T 26661 , F 208, S 8, H M 480498, I/A 8 ( 9.05.11).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: PEAGO M3M SL. Representan: GONZALEZ LOSADA MIGUEL ANGEL.
08/02/2011 Detalles del anuncio (63736)
- Depósitos de cuentas anuales
(Enero de 2011) Año: 2009
27/12/2010 Detalles del anuncio (478896) Datos registrales: T 26661 , F 207, S 8, H M 480498, I/A 7 (15.12.10).
- Nombramientos
Consejero: GARCIA FRANCES FRANCISCO JAVIER.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 16
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2018-166-28 | 29/08/2018 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2016-139-28 | 21/07/2016 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-125-28 | 06/07/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2015-54-28 | 20/03/2015 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-11-28 | 17/01/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-116-28 | 20/06/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-152-28 | 10/08/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-98-28 | 24/05/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2011-26-28 | 08/02/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-246-28 | 27/12/2010 | Madrid | Descargar |